CAPARO INDUSTRIES PLC

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCAPARO INDUSTRIES PLC
    Статус компанииВ управлении
    Организационно-правовая формаПубличная акционерная компания
    Номер компании 00630473
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CAPARO INDUSTRIES PLC?

    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Юридический адрес
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    L.K.INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED16 июн. 1959 г.16 июн. 1959 г.

    Каковы последние отчеты CAPARO INDUSTRIES PLC?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2015 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июн. 2016 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для CAPARO INDUSTRIES PLC?

    ПросроченоДа
    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на14 июн. 2017 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено28 июн. 2017 г.
    ПросроченоДа

    Каков статус последней годовой декларации для CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность
    ПросроченоДа

    Какие последние документы подавались CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    26 страницыAM10

    Отчет о ходе администрации

    28 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    26 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    24 страницыAM10

    Уведомление о назначении замещающего или дополнительного администратора

    3 страницыAM11

    Уведомление о постановлении об освобождении администратора от должности

    14 страницыAM16

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    26 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    26 страницыAM10

    Уведомление о постановлении об освобождении администратора от должности

    14 страницыAM16

    Уведомление о прекращении полномочий управляющего или распорядителя

    8 страницыRM02

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Уведомление о постановлении об освобождении администратора от должности

    18 страницыAM16

    Уведомление о назначении замещающего или дополнительного администратора

    3 страницыAM11

    Отчет о ходе администрации

    30 страницыAM10

    Решение суда по делу о банкротстве

    Court order insolvency:C.O. To file progress reports annually not 6 monthly.
    3 страницыLIQ MISC OC

    Отчет о ходе администрации

    31 страницыAM10

    Юридический адрес изменен с 7 More London Riverside London SE1 2RT на Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL 09 окт. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Уведомление о продлении срока администрации

    2 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    28 страницыAM10

    Кто является должностными лицами CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Секретарь
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    British108203800001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Секретарь
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HYLAND, Matthew Edward William
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Секретарь
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    194838470001
    JEAVONS, William Geoffrey
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    Секретарь
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    British11293410001
    MASON, Georgina
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Секретарь
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    173195350001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Секретарь
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Секретарь
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British10618480001
    STILWELL, Michael James
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Секретарь
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    150882120001
    BUTLER, Richard Gareth John
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    Директор
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    EnglandBritish117859680001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Директор
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    DAWSON, Douglas, Dr
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Директор
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish117734230001
    EMMENEGGER, Charles E
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    Директор
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    United States Of America37965200001
    GANE, Christopher Nigel
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Директор
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    ScotlandBritish73268030001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Директор
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Директор
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    British12310490001
    HAUXWELL, Timothy Norbury
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    Директор
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    British70993740001
    JARVIS, Andrew Laurence
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    Директор
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    United KingdomBritish93158620001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Директор
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LORMOR, Paul Frederick
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    Директор
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    British30814040001
    MEYER, John Joseph
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    Директор
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    UsaAmerican147066260001
    MORRILL, Dennis
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    Директор
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    United KingdomBritish111395730002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Директор
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAHILAJANI, Sunil
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Директор
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Indian119093750001
    PAUL, Akash, The Honourable
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    Директор
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish49303360005
    PAUL, Akhil
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Директор
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish147065830001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Директор
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Директор
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    PAUL, Anjli, The Hon
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Директор
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    United KingdomBritish110279150001
    PAUL OF MARYLEBONE, The Lord
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Директор
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    EnglandBritish11293420003
    PAY, Jason Christopher
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Директор
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish126516810001
    SCHEELE, Nicholas, Sir
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    Директор
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    British American116839800001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Директор
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritish28831060001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Директор
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Директор
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10618480001

    Есть ли у CAPARO INDUSTRIES PLC какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 15 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H real estate:. Cmt engineering, congreaves road, cradley heath t/no WM904133.. Units 9 & 13 -5-7 wenlock road, london t/no's EGL525392, EGL525389 and EGL525391.. Land adjoing walsall canal, old birchills, walsall t/no WM928137. (For further details of properties charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Транзакции
    • 15 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 06 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H land adjoining walsall canal old birchills walsall t/no WM928137. F/h land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood t/no WM664003. F/h land and buildings o the north east side of miner street walsall t/no WM383832. Notification of addition to or amendment of charge.
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Caparo Pensions Scheme Trustee Limited
    Транзакции
    • 06 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    • 222 окт. 2016 г.Назначение приемщика или управляющего (RM01)
    • 222 окт. 2016 г.Назначение приемщика или управляющего (RM01)
    • 213 нояб. 2019 г.Уведомление о прекращении деятельности в качестве приемщика или управляющего (RM02)
      • Дело № 2
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 05 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H land k/a cmt engineering corngreaves road cradley heath t/no WM904133. F/h land (ground lease) k/a units 9 - 5-7 wenlock road london t/nos EGL525392, EGL525389, EGL525394 and EGL525391. Trade mark registered in the UK with number 2623030 in relation to the word mark "barton filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. trade mark registered in the republic of ireland with number N247732 in relation to the word mark "barton" filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Транзакции
    • 05 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 01 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H property being the land adjoining walsall canal old birchills walsall (WM928137) land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood (WM664003) and land and building on the north east side of miner walsall (WM383832). Notification of addition to or amendment of charge.
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Caparo Group Limited
    Транзакции
    • 01 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    Share charge
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 13 авг. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Right title and interest in the shares being 10,000 ordinary shares and all related rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited in Its Capacity as Trustee for the Caparo 1988 Pension Scheme
    Транзакции
    • 13 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Legal mortgage
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 09 авг. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property land adjoining walsall canal, old bircills walsall, t/no.WM928137; land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood, t/no.WM664003; land and buildings on the north east side of miner street walsall, t/no.WM383832 see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 09 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Share charge
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 06 авг. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All shares in caparo india limited and all related rights. See image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 06 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Share charge
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 05 авг. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or geneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Caparo Group Limited
    Транзакции
    • 05 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Share charge
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 05 авг. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Caparo PLC
    Транзакции
    • 05 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Share charge
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 05 авг. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Shares mean in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Caparo Group Limited
    Транзакции
    • 05 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Security agreement
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 06 авг. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 06 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 16 февр. 2009 г.
    Поставлен 18 февр. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a as land lying to the west of raybould's bridge road, reedswood, land adjoining walsall canal, old brichills, walsall and land and buildings to the north east side of miner street, walsall t/no WM66003, WM928137, and WM383832.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 февр. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 февр. 2009 г.
    • 20 февр. 2009 г.
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 05 июл. 2007 г.
    Поставлен 07 июл. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H properties k/a units 9 and 13 and parking spaces 21 and 22 "estilo wenlock road london.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 07 июл. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 23 февр. 2007 г.
    Поставлен 28 февр. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a corngreaves road cradley t/no WM489303.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 28 февр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 05 апр. 1985 г.
    Поставлен 12 апр. 1985 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All ordinary and deferred shared in caparo management services limited held in the name of fenchurch securities LTD. All ordinary and deferred shares in barton group PLC owned by the charger.
    Уполномоченные лица
    • Kleinwort, Benson Limited.
    Транзакции
    • 12 апр. 1985 г.Регистрация залога

    Есть ли у CAPARO INDUSTRIES PLC какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    19 окт. 2015 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Практик
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Практик
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    2Назначен ресивер/менеджер
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Suzanna Vida Marshall
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Ресивер-менеджер
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Andrew Lamb
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Ресивер-менеджер
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0