LGUA17 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииLGUA17 LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00631916
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель LGUA17 LIMITED?

    • Оптовая торговля несосредоточенная (46900) / Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

    Где находится LGUA17 LIMITED?

    Юридический адрес
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия LGUA17 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    UNIPART LEISURE AND MARINE LIMITED02 авг. 2007 г.02 авг. 2007 г.
    H. BURDEN LIMITED03 июл. 1959 г.03 июл. 1959 г.

    Каковы последние отчеты LGUA17 LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для LGUA17 LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на01 мая 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено15 мая 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на01 мая 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались LGUA17 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Прекращение полномочий Ian William David Truesdale в качестве директора 21 янв. 2025 г.

    1 страницыTM01
    XDVRH0E8

    Годовая бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA
    AD76FA3U

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 мая 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XD2QTETS

    Прекращение полномочий Tanya Russell в качестве секретаря 01 мар. 2024 г.

    1 страницыTM02
    XCY0139S

    Назначение Mr Benjamin Lascelles Thornton на должность секретаря 01 мар. 2024 г.

    2 страницыAP03
    XCY0139O

    Назначение Mr Ian William David Truesdale на должность директора 30 июн. 2023 г.

    2 страницыAP01
    XC7KAKGJ

    Годовая бухгалтерская отчетность

    24 страницыAA
    AC5R5KU5

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 мая 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XC2PYURU

    Регистрация обременения 006319160019, создано 31 мар. 2023 г.

    94 страницыMR01
    XC0PNFM0

    Полное погашение обременения 11

    1 страницыMR04
    XBZPV9TS

    Полное погашение обременения 10

    1 страницыMR04
    XBZPVAEJ

    Полное погашение обременения 12

    1 страницыMR04
    XBZPVAN4

    Полное погашение обременения 13

    1 страницыMR04
    XBZPVASX

    Годовая бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA
    ABCNQNNT

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 мая 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XB386S3F

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD
    AAW0RV5T

    Регистрация обременения 006319160017, создано 12 нояб. 2021 г.

    25 страницыMR01
    XAHJQCAZ

    Регистрация обременения 006319160018, создано 12 нояб. 2021 г.

    40 страницыMR01
    XAHJQCKP

    Назначение Mrs Tanya Russell на должность секретаря 06 сент. 2021 г.

    2 страницыAP03
    XAD83JBK

    Годовая бухгалтерская отчетность

    26 страницыAA
    AACRRK1U

    Прекращение полномочий Robert Paul David O'brien в качестве секретаря 31 июл. 2021 г.

    1 страницыTM02
    XAA6TBH5

    Меморандум и Устав

    9 страницыMA
    AA344ZG1

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 мая 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XA3UNSH3

    Регистрация обременения 006319160016, создано 16 мар. 2021 г.

    89 страницыMR01
    XA0MJM6R

    Кто является должностными лицами LGUA17 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    THORNTON, Benjamin Lascelles
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    Oxon
    England
    Секретарь
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    Oxon
    England
    320044540001
    LEUNG, Alex Raymond
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    Директор
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    United KingdomBritishManager150874960001
    WELDON, Christopher James
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    Директор
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    EnglandBritishAccountant179274330001
    LISTER, Eric Charles
    26 Branksea Avenue
    BH15 4DP Poole
    Dorset
    Секретарь
    26 Branksea Avenue
    BH15 4DP Poole
    Dorset
    British12358240001
    O'BRIEN, Robert Paul David
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    Секретарь
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    198417840001
    RIMMER, Michael Douglas
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    Секретарь
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    British48355360001
    RUSSELL, Tanya
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    United Kingdom
    Секретарь
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    United Kingdom
    287401660001
    BOOTH, Roger George
    The Old Rectory North Road
    Chesham Bois
    HP6 5NA Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    The Old Rectory North Road
    Chesham Bois
    HP6 5NA Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector55108590001
    BOOTH, Roger George
    The Old Rectory North Road
    Chesham Bois
    HP6 5NA Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    The Old Rectory North Road
    Chesham Bois
    HP6 5NA Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director55108590001
    BOWYER, Michael Stuart
    The Pumphouse
    Eagle Lane
    NN14 1PR Great Cransley
    Northamptonshire
    Директор
    The Pumphouse
    Eagle Lane
    NN14 1PR Great Cransley
    Northamptonshire
    BritishCompany Director14836900001
    CHITTY, Jonathan
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant124647410003
    CLAYTON, John David
    10 Agden Road
    Nether Edge
    S7 1LY Sheffield
    Yorks
    Директор
    10 Agden Road
    Nether Edge
    S7 1LY Sheffield
    Yorks
    United KingdomBritishManaging Director53687000004
    CULLEN, Philip
    Scuffers Brook
    Cooks Hill, Shutford
    OX15 6PL Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    Scuffers Brook
    Cooks Hill, Shutford
    OX15 6PL Banbury
    Oxfordshire
    BritishMarketing Director86037090001
    DESSAIN, Paul Mark
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant17182840001
    DESSAIN, Paul Mark
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant17182840001
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Директор
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    BritishManaging Director1908570001
    FORMAN, Paul Anthony
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    Директор
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    BritishExecutive59639890001
    GOODEY, Nigel
    7 Yarnells Hill
    OX2 9BD Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    7 Yarnells Hill
    OX2 9BD Oxford
    Oxfordshire
    ScotlandBritishAccountant56600230001
    HUDSON, Terence Nigel
    74 Jervis Crescent
    Streetley
    B74 4PN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Директор
    74 Jervis Crescent
    Streetley
    B74 4PN Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishManaging Director45979350001
    JOHNSTONE, Thomas George
    Abbey Farm
    Cutthorpe Road Cutthorpe
    S42 7AD Chesterfield
    Derbyshire
    Директор
    Abbey Farm
    Cutthorpe Road Cutthorpe
    S42 7AD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant68756380002
    KUIJT, Alphonsus Maria
    Boekweitoord 32
    Houten
    3991 Xm Utrecht
    Holland
    Директор
    Boekweitoord 32
    Houten
    3991 Xm Utrecht
    Holland
    DutchCompany Director55108400001
    LISTER, Eric Charles
    26 Branksea Avenue
    BH15 4DP Poole
    Dorset
    Директор
    26 Branksea Avenue
    BH15 4DP Poole
    Dorset
    BritishCompany Director12358240001
    MOURGUE, Anthony John
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    Директор
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    EnglandBritishAccountant17182830005
    MOURGUE, Anthony John
    115 Coleherne Court
    Old Brompton Road
    SW5 0EB London
    Директор
    115 Coleherne Court
    Old Brompton Road
    SW5 0EB London
    BritishAccountant17182830001
    NEILL, John Mitchell
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    Unipart House
    Garsington Road Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive27195420006
    OHARA, Gerard Francis
    Waterside Heights
    Waterside Shirley
    B90 1UD Solihull
    130
    West Midlands
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Heights
    Waterside Shirley
    B90 1UD Solihull
    130
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales And Marketing Director135522860002
    ROBINSON, Michael William
    3 Skittle Alley
    Aynho
    OX17 3AJ Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    3 Skittle Alley
    Aynho
    OX17 3AJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishMarketing Manager181562410001
    TRUESDALE, Ian William David
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    Директор
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    United KingdomBritishManaging Director288990190001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над LGUA17 LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    06 апр. 2016 г.
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Unipart House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер576777
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у LGUA17 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 31 мар. 2023 г.
    Поставлен 04 апр. 2023 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    See clauses 2.1(a) and 2.1(b), which creates a legal mortgage and (to the extent not effectively mortgaged) a fixed charge over all interests in any freehold or leasehold property now or in the future belonging to it. See clause 2.1(b)(xiii) of the debenture, which creates a first fixed charge over intellectual property now or in the future held by it, including any revenues or other income arising thereunder and any claims for damages arising in respect thereto (as defined in the debenture).
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 04 апр. 2023 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 12 нояб. 2021 г.
    Поставлен 18 нояб. 2021 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank Corporate Markets PLC
    Транзакции
    • 18 нояб. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 12 нояб. 2021 г.
    Поставлен 18 нояб. 2021 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank Corporate Markets PLC
    Транзакции
    • 18 нояб. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 16 мар. 2021 г.
    Поставлен 19 мар. 2021 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 19 мар. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 22 мая 2014 г.
    Поставлен 31 мая 2014 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 31 мая 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    • 11 нояб. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 29 мая 2012 г.
    Поставлен 14 июн. 2012 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 14 июн. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 11 нояб. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    Создан 03 окт. 2011 г.
    Поставлен 13 окт. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed charge the non-vesting debts together with the related rights floating charge the undertaking and all property assets and rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited as Asset Trustee
    Транзакции
    • 13 окт. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 20 мар. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    Создан 31 окт. 2007 г.
    Поставлен 02 нояб. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and any other obligor to teh secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All present and future debts and related rights floating charge all assets property and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Транзакции
    • 02 нояб. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 мар. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Second floating charge
    Создан 19 дек. 2003 г.
    Поставлен 07 янв. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and each other company named therein to the secured parties or any of them under or pursuant to the asset ancillary agreements and/or the charge
    Краткое описание
    By way of second floating charge its undertaking and all its property assets and rights including its property situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Asset Ancillary Trustee for the Secured Parties (The "Asset Ancillary Trustee")
    Транзакции
    • 07 янв. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 мар. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    Создан 19 дек. 2003 г.
    Поставлен 23 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all those of its present and future debts together with the related rights. By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 23 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 мар. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Floating charge and guarantee
    Создан 12 апр. 2001 г.
    Поставлен 25 апр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities of each obligaor to any lender under each finance document which such obligor is a party and tmi under the isda master agreement dated 18TH october 1999 (all terms as defined)
    Краткое описание
    Floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Investment Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and for Eachlender (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 апр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Floating charge and guarantee
    Создан 29 сент. 1999 г.
    Поставлен 14 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any transaction party under each transaction document to which such obligor is a party
    Краткое описание
    By way of a floating charge all its assets except for those contracts, to which it is a party, which by their terms prohibit the creation of a floating charge over or in respect of them.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Investment Bank PLC (The "Security Trustee")
    Транзакции
    • 14 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 30 авг. 1996 г.
    Поставлен 31 авг. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The l/h property k/a land lying to the north of charles avenue coventry west midlands together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge on all present and future book and other debts assigns the good will of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 31 авг. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 авг. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Single debenture
    Создан 22 апр. 1993 г.
    Поставлен 26 апр. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 26 апр. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 дек. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 22 окт. 1988 г.
    Поставлен 26 окт. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a pytchley lodge rd industrial estate kettering northampton T.no nn 49224 together with buildings & fixtures, & goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 26 окт. 1988 г.Регистрация залога
    • 19 дек. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 21 дек. 1987 г.
    Поставлен 29 дек. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Units 3 and 3A pytchley lodge road kettering the benefit of future licenses held.
    Уполномоченные лица
    • Commercial Financial Services Limited
    Транзакции
    • 29 дек. 1987 г.Регистрация залога
    • 20 сент. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 июл. 1987 г.
    Поставлен 24 июл. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £540,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 9.7.87
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • X J K Holdings Limited
    Транзакции
    • 24 июл. 1987 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 28 нояб. 1980 г.
    Поставлен 03 дек. 1980 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    And heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 03 дек. 1980 г.Регистрация залога
    • 19 дек. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 06 февр. 1976 г.
    Поставлен 18 февр. 1976 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 18 февр. 1976 г.Регистрация залога
    • 19 дек. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0