DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииDINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаЧастная компания с ограниченной ответственностью на основе гарантии без акционерного капитала
    Номер компании 00721519
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    • Эксплуатация спортивных объектов (93110) / Искусство, спорт, развлечения и отдых

    Где находится DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    Юридический адрес
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2018 г.

    Какие последние документы подавались DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Graham Matthews в качестве директора 01 апр. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    11 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 апр. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Mr Graham Matthews на должность директора 01 апр. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    9 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 апр. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Прекращение полномочий Richard Parsons в качестве директора 02 нояб. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Прекращение полномочий Richard Parsons в качестве секретаря 01 июл. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Назначение Mr Richard Parsons на должность директора 01 июл. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Anthony Patterson в качестве директора 24 июн. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Anthony Patterson в качестве секретаря 24 июн. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Назначение Mr Richard Parsons на должность секретаря 01 июл. 2016 г.

    2 страницыAP03

    Изменение данных директора для Mrs Sandra Mitchell 02 мая 2016 г.

    2 страницыCH01

    Годовой отчет, список участников не предоставлен

    4 страницыAR01

    Назначение Mrs Sandra Mitchell на должность директора 01 апр. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий John Pennock в качестве директора 31 мар. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Richard Parsons в качестве директора 08 сент. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    4 страницыAA

    Годовой отчет, список участников не предоставлен

    5 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    3 страницыAA

    Кто является должностными лицами DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MITCHELL, Sophia
    The Green
    Norton
    TS20 1DX Stockton-On-Tees
    37
    Cleveland
    England
    Директор
    The Green
    Norton
    TS20 1DX Stockton-On-Tees
    37
    Cleveland
    England
    EnglandEnglishRetired128636990001
    CORCORAN, David William
    5 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    Секретарь
    5 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    BritishRetired47300220001
    DAVISON, Ernest Paul
    31 Whinfell Avenue
    Eaglescliffe
    TS16 0HY Stockton On Tees
    Секретарь
    31 Whinfell Avenue
    Eaglescliffe
    TS16 0HY Stockton On Tees
    BritishSecretary75397970002
    HUGHES, Brynley Robert
    72 High Stell
    Middleton St George
    DL2 1UW Darlington
    County Durham
    Секретарь
    72 High Stell
    Middleton St George
    DL2 1UW Darlington
    County Durham
    British120904060001
    PARSONS, Richard
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    Секретарь
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    211115000001
    PATTERSON, Anthony
    Mayfield Crescent
    Eaglescliffe
    TS16 0NQ Stockton On Tees
    33
    Co Durham
    Секретарь
    Mayfield Crescent
    Eaglescliffe
    TS16 0NQ Stockton On Tees
    33
    Co Durham
    BritishSecretary129264460001
    WRIGHT, Peter James
    46 Edinburgh Drive
    DL3 8AT Darlington
    County Durham
    Секретарь
    46 Edinburgh Drive
    DL3 8AT Darlington
    County Durham
    British5614070001
    CORCORAN, David William
    5 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    Директор
    5 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    BritishRetired47300220001
    COSSINS, Steven
    74 High Stell
    Middleton St. George
    DL2 1UW Darlington
    County Durham
    Директор
    74 High Stell
    Middleton St. George
    DL2 1UW Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishAccountant13304900002
    DAVISON, Ernest Paul
    31 Whinfell Avenue
    Eaglescliffe
    TS16 0HY Stockton On Tees
    Директор
    31 Whinfell Avenue
    Eaglescliffe
    TS16 0HY Stockton On Tees
    BritishSecretary75397970002
    DENNETT, Anthony Michael
    319 Coniscliffe Road
    DL3 8AH Darlington
    County Durham
    Директор
    319 Coniscliffe Road
    DL3 8AH Darlington
    County Durham
    EnglandBritishConsultant52366820001
    FORSTER, Ronald
    3 Villiers Place
    DL5 4JA Newton Aycliffe
    County Durham
    Директор
    3 Villiers Place
    DL5 4JA Newton Aycliffe
    County Durham
    BritishRetired13304910001
    MATTHEWS, Graham
    Neasham Road
    Middleton St. George
    DL2 1DW Darlington
    Dinsdale Spa Golf Club
    England
    Директор
    Neasham Road
    Middleton St. George
    DL2 1DW Darlington
    Dinsdale Spa Golf Club
    England
    EnglandBritishRetired245175060001
    PARK, Kenneth Norman
    204 Coniscliffe Road
    DL3 8PL Darlington
    County Durham
    Директор
    204 Coniscliffe Road
    DL3 8PL Darlington
    County Durham
    BritishRetired69687960001
    PARSONS, Richard
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    Директор
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    EnglandBritishAccountant166068730001
    PARSONS, Richard
    Nunnery Lane
    DL3 9BD Darlington
    26
    County Durham
    England
    Директор
    Nunnery Lane
    DL3 9BD Darlington
    26
    County Durham
    England
    EnglandBritishCertified Chartered Accountant166068730001
    PATTERSON, Anthony
    Mayfield Crescent
    Eaglescliffe
    TS16 0NQ Stockton On Tees
    33
    Co Durham
    Директор
    Mayfield Crescent
    Eaglescliffe
    TS16 0NQ Stockton On Tees
    33
    Co Durham
    United KingdomBritishSecretary129264460001
    PENNOCK, John
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    Директор
    The Dinsdale Spa Golf Club
    Middleton St George
    DL2 1DW Nr Darlington
    Co Durham
    EnglandEnglishRetired168440140001
    SMITH, William Nicholson
    Glenair Dalton Road
    Croft On Tees
    DL2 2SX Darlington
    County Durham
    Директор
    Glenair Dalton Road
    Croft On Tees
    DL2 2SX Darlington
    County Durham
    BritishRetired16818450001
    STUDHOLME, Guy Archibold
    Alonby Court
    TS21 3JU Long Newton
    1
    Stockton-On-Tees
    Директор
    Alonby Court
    TS21 3JU Long Newton
    1
    Stockton-On-Tees
    United KingdomBritishRetired13670120001
    TRURAN, Terry
    7 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    Директор
    7 Ryedale Close
    TS15 9UN Yarm
    Cleveland
    EnglandBritishAccountant43576390002
    WRIGHT, Peter James
    46 Edinburgh Drive
    DL3 8AT Darlington
    County Durham
    Директор
    46 Edinburgh Drive
    DL3 8AT Darlington
    County Durham
    BritishRetired5614070001

    Каковы последние заявления о лицах, осуществляющих значительный контроль над DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE)?

    Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
    УведомленПрекращеноЗаявление
    02 апр. 2017 г.Компания знает или имеет разумные основания полагать, что в отношении компании нет ни одного регистрируемого лица или регистрируемого соответствующего юридического лица.

    Есть ли у DINSDALE SPA GOLF CLUB LIMITED(THE) какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Legal mortgage
    Создан 23 окт. 1996 г.
    Поставлен 25 окт. 1996 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The club house, car park, practice ground and golf course k/a the dinsdale spa golf club situate at middleton st george darlington in the county of durham the company assigns to the bank: any option to purchase or right of pre-emption to acquire the f/h or superior l/h or to have a new lease of the property; any proceeds of sale, letting or other disposition of the property; any guarantees, insurance or compensation monies relating to the property or any authorisation, permit, registration certificate or licence of any kind in force in connection with the property; and share or membership rights in a residents' association or management company relating to the property; and any other benefit or right of any kind relating to the property, its use, construction or title. The company assigns to the bank the goodwill belonging to the company of all business from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind which the company may hold in connection with such businesses. The company also charges to the bank by way of fixed charge the equipment and goods (if any) listed in schedule 2 and all otherfixtures, fittings, plant and machinery, which may from time to time be erectred on or affixed to the property, and by way of floating charge all other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods and other effects which are from time to time on the property.
    Уполномоченные лица
    • Yorkshire Bank PLC
    Транзакции
    • 25 окт. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 27 сент. 1984 г.
    Поставлен 03 окт. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Sterling pounds 6000 and any monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Краткое описание
    Plots of land situated on the road leading from middleton st george to neasham in the county of durham.
    Уполномоченные лица
    • John Smith's Tadcaster Brewery Limited
    Транзакции
    • 03 окт. 1984 г.Регистрация залога
    • 24 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 25 сент. 1984 г.
    Поставлен 26 сент. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Sterling pounds 7,000 and all monies due or to become due from the company and/or J.W. cameron & co. To the chargee
    Краткое описание
    Land situate on the road leading from middleton st. George to neasham in the county of durham together with buildings erected thereon or upon and k/a dinsdale s/a golf club, middleton st. George. Together with thereon all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 26 сент. 1984 г.Регистрация залога
    • 24 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0