REASSURE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииREASSURE LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00754167
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель REASSURE LIMITED?

    • Страхование жизни (65110) / Финансовая и страховая деятельность
    • Финансирование пенсионного обеспечения (65300) / Финансовая и страховая деятельность

    Где находится REASSURE LIMITED?

    Юридический адрес
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия REASSURE LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    WINDSOR LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED20 мар. 1963 г.20 мар. 1963 г.

    Каковы последние отчеты REASSURE LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для REASSURE LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на01 июн. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено15 июн. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на01 июн. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались REASSURE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Прекращение полномочий Nicholas Hugh Poyntz-Wright в качестве директора 31 дек. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Martin John Muir на должность директора 01 янв. 2025 г.

    2 страницыAP01

    Меморандум и Устав

    30 страницыMA

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Capitalisation 21/11/2024
    RES13
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Отчет о капитале на 22 нояб. 2024 г.

    • Капитал: GBP 254,942,951
    3 страницыSH19

    legacy

    2 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Cancel share premium 21/11/2024
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Отчет о капитале после размещения акций 21 нояб. 2024 г.

    • Капитал: GBP 1,069,632,655
    3 страницыSH01

    Прекращение полномочий Brid Mary Meaney в качестве директора 19 авг. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Rakesh Kishore Thakrar в качестве директора 31 июл. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    92 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 июн. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Mrs Karin Alexandra Cook на должность директора 01 мая 2024 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Amanda Helen Bowe в качестве директора 30 апр. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mrs Arlene Cairns на должность директора 01 апр. 2024 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Peter Kane Mayes в качестве директора 31 мар. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Регистрация обременения 007541670057, создано 15 дек. 2023 г.

    17 страницыMR01

    Изменение данных о Reassure Midco Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 21 февр. 2019 г.

    2 страницыPSC05

    Изменение данных директора для Mrs Rosemary Harris 25 апр. 2023 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Jora Gill 01 июн. 2023 г.

    2 страницыCH01

    Судебное постановление

    S1096 Court Order to Rectify
    3 страницыOC

    Полное погашение обременения 007541670054

    1 страницыMR04

    Изменение данных директора для Mr Andrew David Briggs 13 окт. 2023 г.

    2 страницыCH01

    Все имущество или предприятие освобождены от обременения 007541670054

    5 страницыMR05

    Кто является должностными лицами REASSURE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LTD
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Секретарь компании
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер03588041
    272294060001
    BRIGGS, Andrew David
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    Директор
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director75581620003
    CAIRNS, Arlene
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomBritishFinance Director235587060001
    COOK, Karin Alexandra
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director322674140001
    CRASTON, Ian Adam
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomBritishNon Executive Director / Pension Trustee309735150001
    CURRAN, Bernard Andrew
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomBritishChief Executive128458310001
    GILL, Jora Singh
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomBritishNon Executive Director286414330001
    HARRIS, Rosemary
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishDirector228468970002
    HARRIS, Timothy Walter
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishAccountant296490400001
    LISTER, John Robert
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishDirector80609740002
    MUIR, Martin John
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishNon Executive Director330779660001
    CAMPBELL, Iain Fraser
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Секретарь
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    BritishDirector98269220002
    COLLOFF, Lyn Carol
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    Секретарь
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    British3771140003
    LEWIS, Sarah
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Секретарь
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British113431840001
    NASH, Andrew
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Секретарь
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    148420750001
    REID, Norman Haydn
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    Секретарь
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    British3771150001
    REID, Norman Haydn
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    Секретарь
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    British3771150001
    SHAKESPEARE, Paul
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Секретарь
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    180959890001
    SHAKESPEARE, Paul
    Upton Lane
    TF11 9HF Shifnal
    The Farthings
    Shropshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Upton Lane
    TF11 9HF Shifnal
    The Farthings
    Shropshire
    United Kingdom
    British135096740002
    SHAKESPEARE, Paul
    17 Kew Gardens
    Priorslee
    TF2 9SY Telford
    Shropshire
    Секретарь
    17 Kew Gardens
    Priorslee
    TF2 9SY Telford
    Shropshire
    BritishCompany Secretary70841590001
    BAXTER, David Jonathan Allen
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Директор
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    BritishAppointed Actuary117650450001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Директор
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritishDirector106900580001
    BOWE, Amanda Helen
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    ScotlandBritishDirector166373510001
    BRIDGEWATER, Allan
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Директор
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    BritishDirector484540003
    BURTON, Geoffrey Michael
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    Директор
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    BritishExecutive Investment56942980001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Директор
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrishDirector63716360005
    CLARKE, Stephen Andrew
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishDirector42862450003
    CRAINE, Roger
    TF3 4NB Telford
    Winsor House
    Shropshire
    Директор
    TF3 4NB Telford
    Winsor House
    Shropshire
    United KingdomBritishAccountant89585440001
    CROTTY, James Francis
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomIrishDirector107951170001
    CUHLS, Matthew Hilmar
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    EnglandBritishChief Executive36427940004
    DIXON, Michael
    5 Arden Close
    RG12 2SG Bracknell
    Berkshire
    Директор
    5 Arden Close
    RG12 2SG Bracknell
    Berkshire
    BritishExecutive Director Sales Agency68176320001
    DUBOIS, Jacques Ernest
    524 Lake Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Директор
    524 Lake Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    AmericanDirector71582930001
    DUNNE, Brian Gerard
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    IrelandIrishDirector227282370001
    EAKINS, Michael John
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Директор
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    United KingdomIrishGroup Chief Investment Officer272316420001
    EDGINGTON, James Figg
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    Директор
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    BritishExecutive Director Administration28278640001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над REASSURE LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Reassure Midco Limited
    Ironmasters Way
    Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    England
    06 апр. 2016 г.
    Ironmasters Way
    Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер02970583
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у REASSURE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 15 дек. 2023 г.
    Поставлен 20 дек. 2023 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    N/A.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Goldman Sachs International
    Транзакции
    • 20 дек. 2023 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 июл. 2023 г.
    Поставлен 14 авг. 2023 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Countrywide Assured PLC
    Транзакции
    • 14 авг. 2023 г.Регистрация залога (MR01)
    Rent deposit deed
    Создан 05 сент. 2008 г.
    Поставлен 13 сент. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £154,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    £154,000.00.
    Уполномоченные лица
    • Target Sports Limited
    Транзакции
    • 13 сент. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 янв. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of security assignment
    Создан 04 июн. 2007 г.
    Поставлен 22 июн. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The assigned property means, cash, collateral account(s) means account numbered 751285. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Zurich Assurance LTD
    Транзакции
    • 22 июн. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of charge
    Создан 23 окт. 2006 г.
    Приобретен 31 дек. 2016 г.
    Поставлен 26 окт. 2017 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Floating charge in respect of all the right to and title in the charged property.
    Уполномоченные лица
    • Countrywide Assured PLC
    Транзакции
    • 26 окт. 2017 г.Регистрация приобретения (MG06)
    • 28 нояб. 2021 г.Все имущество или предприятие освобождено от залога (MR05)
    • 06 сент. 2023 г.Все имущество или предприятие освобождено от залога (MR05)
    • 30 окт. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 15 мая 2000 г.
    Поставлен 19 мая 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Monies due in accordance with the terms of clause 12 of an agreement dated 8 february 2000 made between maurice john edmonds and elizabeth edmonds (1) and belgrave land limited (2) as varied by an agreement dated 15 may 2000 made between the edmonds (1) belgrave land limited (2) and belgrave land (hemel hempstead) limited (3)
    Краткое описание
    The land and premises k/a ethylwin buncefield lane hemel hempstead hertfordshire.
    Уполномоченные лица
    • Elizabeth Edmonds
    • Maurice John Edmonds
    Транзакции
    • 19 мая 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июн. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 10 нояб. 1995 г.
    Поставлен 21 нояб. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £686,500 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Unit 1/4 wycke hill business park maldon essex.
    Уполномоченные лица
    • Essex County Council
    Транзакции
    • 21 нояб. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 нояб. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 04 окт. 1994 г.
    Поставлен 25 окт. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H 15 bennett road reading berks.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 25 окт. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Standard security
    Создан 14 сент. 1994 г.
    Поставлен 27 сент. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 14/9/94 pursuant to the terms of a personal bond dated 2/7/90 or any variation or alteration thereof
    Краткое описание
    41 ashfield street glasgow t/no gla 28710.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 27 сент. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 янв. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 18 окт. 1993 г.
    Поставлен 02 нояб. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The stable block beckbury hall beckbury shropshire t/no SL51351.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 02 нояб. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland
    Создан 29 июл. 1993 г.
    Поставлен 17 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Ground at gledfield in the parish of kincardine county of ross & cromarty.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 17 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 июл. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Создан 29 июл. 1993 г.
    Поставлен 17 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Ground k/a howeshalloch, partly in the county of aberdeen.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 17 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 июл. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Создан 09 июл. 1993 г.
    Поставлен 17 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Ground k/a and forming struthan dubh in the parish of edderton in the county of ross & cromarty.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 17 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 июл. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 окт. 1992 г.
    Поставлен 15 окт. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H 837 fulham rd. Fulham london t/n NGL321231.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 15 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 09 окт. 1992 г.
    Поставлен 13 окт. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H office and dwelling on two floors AT22/24 leazes crescent newcastle on tyne t/n nd 7841.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 13 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 янв. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 24 сент. 1991 г.
    Поставлен 25 сент. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All that f/a property k/a 15 bennet road reading berkshire t/no bk 276490 (please see doc 395/m/104/c/26.9.91 For full details).
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 25 сент. 1991 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 08 июл. 1991 г.
    Поставлен 13 июл. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a 12 duke street london sw 1 t/no:- ngl 273269 with all fixtures & fittings by way of a fixed charge overall the plant machinery implements utensils furniture and equipment. (Please see doc 395/m/160/c 16/791 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Hambros Bank Limited
    Транзакции
    • 13 июл. 1991 г.Регистрация залога
    • 07 янв. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 28 мар. 1991 г.
    Поставлен 03 апр. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    1) 31 and 32 park parade hazelmere and garages 38, 39, 40, 41, 42 and 43. 2) the amount standing to the credit of the mortgagors segregated fund entitled tayberry segregated pension fund.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 03 апр. 1991 г.Регистрация залога
    • 09 дек. 1997 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 28 февр. 1991 г.
    Поставлен 14 мар. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Unit 30 park royal metro centre brittenia way NW10. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 14 мар. 1991 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 15 нояб. 1990 г.
    Поставлен 20 нояб. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All that property k/a 13 sackville road bexhill on sea.
    Уполномоченные лица
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 нояб. 1990 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 06 нояб. 1990 г.
    Поставлен 08 нояб. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The old post office kingfield road woking surrey. 2. the amount from time to time standing to the credit of the mortgagors segregated fund entitled j j's estates pension scheme.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 нояб. 1990 г.Регистрация залога
    • 27 янв. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 15 авг. 1990 г.
    Поставлен 16 авг. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Property k/a 57 high street lincoln with all buildings and fixtures thereon by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • The Co-Operative Bank PLC
    Транзакции
    • 16 авг. 1990 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 15 авг. 1990 г.
    Поставлен 16 авг. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Legal mortgage over the property k/a 55 high street, lincoln with all buildings and fixtures thereon by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • The Co-Operative Bank PLC
    Транзакции
    • 16 авг. 1990 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 09 июл. 1990 г.
    Поставлен 27 июл. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    62 gloucester place 7 borough of city of westminster. The balance from time to time standing to the credit of the companys segregated fund entitled the retirement benefit scheme ("the fund").
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 27 июл. 1990 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 01 мая 1990 г.
    Поставлен 04 мая 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/A property k/a 109B hillview avenue hornchurch essex such amount as shall from time to time be standing to the credit of the mortgagors segregated land entitled swift credit retirement benefit scheme.
    Уполномоченные лица
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 04 мая 1990 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0