CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00938188
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Юридический адрес
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    YEWLANDS ENGINEERING CO.LIMITED 03 сент. 1968 г.03 сент. 1968 г.

    Каковы последние отчеты CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на27 дек. 2020 г.

    Какие последние документы подавались CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    2 страницыDS01

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Меморандум и Устав

    35 страницыMA

    Отчет о капитале на 09 дек. 2022 г.

    • Капитал: GBP 1
    5 страницыSH19

    legacy

    2 страницыSH20

    legacy

    2 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Cancel share premium account 07/12/2022
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Процедура принудительной ликвидации прекращена

    1 страницыDISS40

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    1 страницыAA

    Прекращение полномочий Joe Snowden в качестве директора 31 авг. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Inderjit Kumar Rattu в качестве директора 31 авг. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Neil David Roebuck на должность директора 31 авг. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr James Robert Puetz на должность директора 01 июл. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Roger Paul Becker в качестве директора 30 июн. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    1 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    1 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Mr Inderjit Kumar Rattu на должность директора 15 февр. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Monika Anna Bailey в качестве директора 21 дек. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    FREEMAN-MASSEY, Janet
    Barkby Road
    Sps Technologies Limited
    LE4 9HX Leicester
    191
    England
    Секретарь
    Barkby Road
    Sps Technologies Limited
    LE4 9HX Leicester
    191
    England
    202782010001
    ARMANGO, Anna Marie
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Директор
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    United StatesAmericanDirector251228780001
    BEYER, Ruth Ann
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    Usa
    Директор
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    Usa
    Unites StatesAmericanSenior Vp, General Counsel And Assistant Secretary181546570001
    HAGEL, Shawn
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    Директор
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    United StatesAmericanExecutive Vp92352720002
    PUETZ, James Robert
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Директор
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    United StatesAmericanCompany Director284954720001
    ROEBUCK, Neil David
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Директор
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    EnglandBritishCompany Director169015260001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Секретарь
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    ASHE, Vincent
    5 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    Секретарь
    5 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    BritishFinance Director38769370001
    BAILEY, Monika Anna
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Секретарь
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    148279150002
    BIRD, Julian Patrick
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    Секретарь
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    British16939950002
    POULTNEY, Nigel Charles
    38 Stapleton Road
    B80 7RH Studley
    Warwickshire
    Секретарь
    38 Stapleton Road
    B80 7RH Studley
    Warwickshire
    British8488600001
    SWINSCOE, John William
    37 Birkdale Close
    Edwalton
    NG12 4FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    37 Birkdale Close
    Edwalton
    NG12 4FB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishAircraft Engineer174203940001
    WALLIS, Michael Raymond
    2 Bailey Close
    LE11 3PB Loughborough
    Leicestershire
    Секретарь
    2 Bailey Close
    LE11 3PB Loughborough
    Leicestershire
    English16864370002
    ASHE, Vincent
    5 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    Директор
    5 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    BritishFinance Director38769370001
    BAILEY, Monika Anna
    c/o Sps Aerostructures Limited
    Willow Drive
    Annesley
    NG15 0DP Nottingham
    Unit 21a
    England
    Директор
    c/o Sps Aerostructures Limited
    Willow Drive
    Annesley
    NG15 0DP Nottingham
    Unit 21a
    England
    EnglandUnited KingdomFinance Director200802490001
    BARRETT, Sean Colin
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Директор
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    United KingdomBritishManaging Director175146510001
    BECKER, Roger Paul
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    Директор
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    United StatesAmericanVp Of Corporate Taxes134923120001
    BLACKMORE, Steven Craig
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    Директор
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    United StatesAmericanVice President & Treasurer129100160001
    COGHLAN, David John
    The Old Rectory
    Long Newnton
    GL8 8RR Tetbury
    Glos
    Директор
    The Old Rectory
    Long Newnton
    GL8 8RR Tetbury
    Glos
    EnglandBritish,AustralianCompany Director35532810001
    COOKE, Roger Anthony
    1910 Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    Oregon
    United States
    Директор
    1910 Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    Oregon
    United States
    UsaUsaSenior Vp & General Counsel134747640001
    DEE, James Digiacomo
    116 Stokes Road
    Medford Lakes
    New Jersey
    08055
    Usa
    Директор
    116 Stokes Road
    Medford Lakes
    New Jersey
    08055
    Usa
    AmericanLawyer61568250002
    DONEGAN, Mark
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    Директор
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    AmericanCompany Chairman And Ceo90933260002
    DUNLOP, Michael H S
    18529 186th Pl Ne
    Woodinville
    98072 Washington
    U.S.A
    Директор
    18529 186th Pl Ne
    Woodinville
    98072 Washington
    U.S.A
    BritishCompany Director34497020001
    ELDRED, Stephen Derrick
    8 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    Директор
    8 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    BritishFinance Director45710290001
    HAWKES, Geoffrey A
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Директор
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Us CitizenVice President And Treasurer76227940001
    KEARNEY, Matthew Joseph
    62 Radnor Road
    KT13 8JU Weybridge
    Surrey
    Директор
    62 Radnor Road
    KT13 8JU Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Director37607620001
    KIRK, Michael David
    46 Shirley Road
    LE2 3LJ Leicester
    Leicestershire
    Директор
    46 Shirley Road
    LE2 3LJ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director8642430002
    LARSSON, William Dean
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    Директор
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    AmericanSebior President And Chief Fin96758530001
    MARTIN, Haydn Robert
    31 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    West Midlands
    Директор
    31 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director65996670001
    MASTERMAN, Andrew Van Rensselaer
    Highland Avenue
    19046 Jenkintown
    301
    Pennsylvania
    Usa
    Директор
    Highland Avenue
    19046 Jenkintown
    301
    Pennsylvania
    Usa
    UsaUnited StatesPresident181401520001
    MORRASH, John
    3901 Sherwood Lane
    FOREIGN Doylestown Pennsylvania
    Bucks County 18901
    Usa
    Директор
    3901 Sherwood Lane
    FOREIGN Doylestown Pennsylvania
    Bucks County 18901
    Usa
    UsFinancial Manager29174810001
    PATTEE, Russell Scott
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    Директор
    Sw Macadam Avenue
    Suite 300
    97239 Portland
    4650
    Oregon
    United States
    United StatesAmericanVp And Corporate Controller132606280001
    PEARSON, Leonard Albert
    Ashcombe Herington Grove
    Hutton
    CM13 2NW Brentwood
    Essex
    Директор
    Ashcombe Herington Grove
    Hutton
    CM13 2NW Brentwood
    Essex
    BritishManaging Director53735710001
    RAMPTON, Geoffrey Roy
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    Директор
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant12413300001
    RATTU, Inderjit Kumar
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Директор
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    EnglandBritishCompany Director129102350001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Sps Chevron Limited
    Barkby Road
    LE4 9HX Leicester
    191
    England
    06 апр. 2016 г.
    Barkby Road
    LE4 9HX Leicester
    191
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеIncorporated Under The Laws Of England And Wales
    Место регистрации191 Barkby Road, Leicester Le49hx
    Регистрационный номер03645978
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Mortgage debenture
    Создан 06 авг. 1997 г.
    Поставлен 20 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 24 янв. 1997 г.
    Поставлен 14 февр. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from quadrant group PLC to the chargee under the terms of the collateral instruments (as defined in the charge)
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lyon Burwell Limited
    Транзакции
    • 14 февр. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 12TH december 1994 issued by the company
    Создан 09 окт. 1996 г.
    Поставлен 18 окт. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Краткое описание
    All right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 4TH december 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 окт. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed & floating charges
    Создан 12 дек. 1995 г.
    Поставлен 29 дек. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Краткое описание
    All debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Транзакции
    • 29 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 18 июл. 1995 г.
    Поставлен 20 июл. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £215,000 and all other monies due from the company to the chargee
    Краткое описание
    One yamazaki mazak horizontal nc lathe super quickturn 18MY ser no 114036 one yamazaki mazak vertical machining centre vtc 16 cb ser no 116171.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 20 июл. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 12 дек. 1994 г.
    Поставлен 16 дек. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 дек. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge.
    Создан 18 мар. 1994 г.
    Поставлен 30 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    35-41 (odd numbers) fowler road, hainault industrial estate, redbridge,london.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 мар. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 21 мар. 1984 г.
    Поставлен 28 мар. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Premises known as 35/41 fowler rd, hainault, essex.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 28 мар. 1984 г.Регистрация залога
    • 09 февр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 20 июл. 1981 г.
    Поставлен 27 июл. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H 56/58 fowler rd, hainault, essex. Egl 26444.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 27 июл. 1981 г.Регистрация залога
    Legal charge
    Создан 20 июл. 1981 г.
    Поставлен 27 июл. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H 35/41 fowler rd, hainault, essex egl 88861.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 27 июл. 1981 г.Регистрация залога
    Charge
    Создан 20 июл. 1981 г.
    Поставлен 27 июл. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 27 июл. 1981 г.Регистрация залога
    • 14 нояб. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Aircraft mortgage
    Создан 23 мар. 1981 г.
    Поставлен 01 апр. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Hughes 500D helicopter serial/no.832D reg/no.g-peni.
    Уполномоченные лица
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Транзакции
    • 01 апр. 1981 г.Регистрация залога
    Mortgage
    Создан 30 окт. 1980 г.
    Поставлен 18 нояб. 1980 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Aircraft reg. No g-bfay serial no. 670148D.
    Уполномоченные лица
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Транзакции
    • 18 нояб. 1980 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0