00938719 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компании00938719 LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00938719
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель 00938719 LIMITED?

    • (9999) /

    Где находится 00938719 LIMITED?

    Юридический адрес
    Springmill Street
    BD5 7HW Bradford
    West Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия 00938719 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    COMPAIR BROOMWADE LIMITED08 нояб. 1984 г.08 нояб. 1984 г.
    COMPAIR INDUSTRIAL LIMITED12 сент. 1968 г.12 сент. 1968 г.

    Каковы последние отчеты 00938719 LIMITED?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2011 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2012 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2010 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для 00938719 LIMITED?

    ПросроченоДа
    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на29 авг. 2016 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено12 сент. 2016 г.
    ПросроченоДа

    Каков статус последней годовой декларации для 00938719 LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность
    ПросроченоДа

    Какие последние документы подавались 00938719 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Прекращение полномочий Brent Andrew Walters в качестве директора 06 авг. 2013 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Michael Meyer Larsen в качестве директора 30 авг. 2013 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Andrew Roger Schiesl на должность директора 04 февр. 2022 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Michael Joseph Scheske на должность директора 04 февр. 2022 г.

    2 страницыAP01

    Восстановление по решению суда

    5 страницыAC92

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed compair uk\certificate issued on 09/06/14
    CERTNM

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале после размещения акций 20 дек. 2011 г.

    • Капитал: GBP 14,494,246
    4 страницыSH01

    Отчет о капитале на 30 дек. 2011 г.

    • Капитал: GBP 2
    4 страницыSH19

    Решения

    Resolutions
    20 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Re issue of shares 20/12/2011
    RES13

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Reduce share prem a/c to nil 20/12/2011
    RES13

    legacy

    7 страницыMG02

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    22 страницыAA

    Назначение Mr Michael Meyer Larsen на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Helen Cornell в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Изменение данных директора для John Dennis Shull 01 июн. 2010 г.

    2 страницыCH01

    Прекращение полномочий John Shull в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами 00938719 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GRUMMETT, Mark Elliott
    21 Lowther Drive
    Garforth
    LS25 1EW Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    21 Lowther Drive
    Garforth
    LS25 1EW Leeds
    West Yorkshire
    United Kingdom114840200001
    SCHESKE, Michael Joseph
    Cross Lane
    Tong
    BD4 0SU Bradford
    PO BOX 468
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Cross Lane
    Tong
    BD4 0SU Bradford
    PO BOX 468
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanAccountant301859300001
    SCHIESL, Andrew Roger
    Cross Lane
    Tong
    BD4 0SU Bradford
    PO BOX 468
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Cross Lane
    Tong
    BD4 0SU Bradford
    PO BOX 468
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector287332200001
    COLES, Richard Paul Atwell
    30 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    Секретарь
    30 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    British3097780001
    SAUNDERS, Richard Meirion
    11 Ferndale Close
    Stokenchurch
    HP14 3NT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Секретарь
    11 Ferndale Close
    Stokenchurch
    HP14 3NT High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary83280910001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Секретарь компании
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    ALLEN, Duncan John
    56 Harwood Road
    SL7 2AS Marlow
    Buckinghamshire
    Директор
    56 Harwood Road
    SL7 2AS Marlow
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director30253120001
    AMOS, Stuart Roland
    7125 Argonauta Way
    92009 Carlsbad
    California
    Usa
    Директор
    7125 Argonauta Way
    92009 Carlsbad
    California
    Usa
    BritishBusiness Executive56930740001
    ARMBRUST, Richard
    2045 Derrin Lane
    53045 Brookfield
    Wisconsin 53045
    United States
    Директор
    2045 Derrin Lane
    53045 Brookfield
    Wisconsin 53045
    United States
    UsaAmericanChief Executive117790370001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    Директор
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishDirector40752710001
    CHESHIRE, Robert Leslie
    41 Birchdale
    SL9 7JB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Директор
    41 Birchdale
    SL9 7JB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director83284450002
    CLAYTON, John Reginald William
    Matley House
    Grange Lane, Little Dunmow
    CM6 3HY Great Dunmow
    Essex
    Директор
    Matley House
    Grange Lane, Little Dunmow
    CM6 3HY Great Dunmow
    Essex
    EnglandBritishSolicitor & Company Secretary28326930001
    COCHRANE, Adam Craven
    41 Highfield Drive
    UB10 8AW Uxbridge
    Middlesex
    Директор
    41 Highfield Drive
    UB10 8AW Uxbridge
    Middlesex
    BritishAccountant54618590001
    COLES, Richard Paul Atwell
    30 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    Директор
    30 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    BritishSolicitor3097780001
    CORNELL, Helen Wright
    205 South 16th Street
    Quincy
    Illinois 62301
    Usa
    Директор
    205 South 16th Street
    Quincy
    Illinois 62301
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Executive103330150001
    COX, Philip Gotsall
    Thatch Cottage
    Collinswood Road
    SL2 3LH Farnham Common
    Berkshire
    Директор
    Thatch Cottage
    Collinswood Road
    SL2 3LH Farnham Common
    Berkshire
    EnglandBritishExecutive72637920001
    DORAN, Colm Paul
    Marley Cottage
    24 Danes Way, Oxshott
    KT22 0LX Leatherhead
    Surrey
    Директор
    Marley Cottage
    24 Danes Way, Oxshott
    KT22 0LX Leatherhead
    Surrey
    BritishQuality Director69683020001
    DUTNALL, Robert James
    32 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    Директор
    32 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    United KingdomBritishChief Fin And Dep Chief Exec O144310800001
    EDMUNDS, John
    65 Compton Avenue
    BH14 8PX Poole
    Dorset
    Директор
    65 Compton Avenue
    BH14 8PX Poole
    Dorset
    BritishVice President Operations83284220001
    FAIRS, John
    Crieff House
    NN7 8BZ Bilsworth
    Northamptonshire
    Директор
    Crieff House
    NN7 8BZ Bilsworth
    Northamptonshire
    BritishManaging Director51291610001
    FISHWICK, Anthony
    5 Ruskin Way
    Woosehill
    RG11 9BP Wokingham
    Berkshire
    Директор
    5 Ruskin Way
    Woosehill
    RG11 9BP Wokingham
    Berkshire
    BritishManufacturing Director45843280001
    GALE, Peter Charles
    9 The Poplars
    Launton
    OX6 0DW Bicester
    Oxfordshire
    Директор
    9 The Poplars
    Launton
    OX6 0DW Bicester
    Oxfordshire
    BritishEngineer30253140001
    HARRISON, Michael John
    35 Abingdon Road
    Sandhurst
    GU17 8RN Camberley
    Surrey
    Директор
    35 Abingdon Road
    Sandhurst
    GU17 8RN Camberley
    Surrey
    BritishManaging Director60922870001
    ING, Brian Donald
    Greencroft Bartons Road
    Tylers Green
    HP10 8JN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Директор
    Greencroft Bartons Road
    Tylers Green
    HP10 8JN High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishFinancial Director/Co Secretary53195840001
    KEEGAN, Nicholas Francis
    Alderminster Lodge
    Alderminster
    CV37 8NY Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Директор
    Alderminster Lodge
    Alderminster
    CV37 8NY Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Finance Officer103638150001
    LARSEN, Michael Meyer
    Gardner Expressway
    Quincy
    Il 62305
    1800
    Usa
    Директор
    Gardner Expressway
    Quincy
    Il 62305
    1800
    Usa
    United StatesDanishVice President And Chief Financial Officer155426730001
    MANN, Roger
    13 Beverley Close
    Lingwood
    GU15 1HF Camberley
    Surrey
    Директор
    13 Beverley Close
    Lingwood
    GU15 1HF Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant36110750001
    MCMAHON, Brian Douglas
    Flat 5 1 Hyde Park Street
    W2 2JW London
    Директор
    Flat 5 1 Hyde Park Street
    W2 2JW London
    AmericanPresident & Dce35151750002
    PARSONS, Howard Robert
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    Директор
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    BritishDirector108355830001
    PEUSSA, Juoko Tapani
    Townside
    Haddenham
    HP17 8BG Aylesbury
    The Turn
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Директор
    Townside
    Haddenham
    HP17 8BG Aylesbury
    The Turn
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    FinnishVice President Technology83284120002
    ROBERTS, Stephen Thomas
    Brookfields
    New Road Cutnall Green
    WR9 0PQ Droitwich
    Worcestershire
    Директор
    Brookfields
    New Road Cutnall Green
    WR9 0PQ Droitwich
    Worcestershire
    BritishDirector108355570001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    26 Hardwick Road
    Little Aston
    B74 3BX Sutton Coldfield
    Staffordshire
    Директор
    26 Hardwick Road
    Little Aston
    B74 3BX Sutton Coldfield
    Staffordshire
    UkBritishChief Executive Officer83283880001
    SHULL, John Dennis
    South 38th Street
    Quincy
    1111
    Illinois 62305
    Usa
    Директор
    South 38th Street
    Quincy
    1111
    Illinois 62305
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive135724830001
    SHUR, Irwin Michael
    15215 Turnberry Drive
    Brookfield
    Wi
    53005
    United States
    Директор
    15215 Turnberry Drive
    Brookfield
    Wi
    53005
    United States
    AmericanVp & Division Legal Counsel71152390001
    SIME, Alan
    Pit Cottage
    Blymhill Lawn
    TF11 8LT Shifnal
    Staffordshire
    Директор
    Pit Cottage
    Blymhill Lawn
    TF11 8LT Shifnal
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector51759580002

    Есть ли у 00938719 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 13 окт. 2006 г.
    Поставлен 27 окт. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Транзакции
    • 27 окт. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 дек. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 04 авг. 2006 г.
    Поставлен 25 авг. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    £3,000 and all other monies due or to become due
    Краткое описание
    The initial deposit and any other sums from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account.
    Уполномоченные лица
    • Blueprint (General Partner) Limited and Blueprint (Nominees) Limited
    Транзакции
    • 25 авг. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Rent deposit deed
    Создан 03 мая 2006 г.
    Поставлен 12 мая 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    A rent deposit of £5,601.
    Уполномоченные лица
    • Monticello (Windsor) Limited
    Транзакции
    • 12 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 18 авг. 2005 г.
    Поставлен 01 сент. 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    £332,523.45 and all other monies due or to become due
    Краткое описание
    Rs components push & turn camlock invoice number 6252727,rs components push & turn camlock invoice number 6252727,kramer ait intake attenuator invoice number wp/4036 serial no 30/140 (for details of further goods charged please refer to form 395) together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books,manuals,handbooks. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 01 сент. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    Deed of charge
    Создан 04 авг. 2003 г.
    Поставлен 11 авг. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Burdale Financial Limited
    Транзакции
    • 11 авг. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 дек. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A supplemental debenture, supplemental to a composite guarantee and debenture dated 4 july 2002 and made between the company and others (charging companies) and compair finance
    Создан 20 янв. 2003 г.
    Поставлен 24 янв. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first legal mortgage the l/h land k/a the car park lying to the south of hughenden avenue, high wycombe forming part of title number BM138685, together with all buildings and fixtures thereon;.
    Уполномоченные лица
    • Compair Finance Limited
    Транзакции
    • 24 янв. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 нояб. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Создан 07 янв. 2003 г.
    Поставлен 22 янв. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Barclays bank PLC re compair UK limited barclays business premium account number 00585998. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 22 янв. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 04 июл. 2002 г.
    Поставлен 20 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 авг. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 04 июл. 2002 г.
    Поставлен 12 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from any principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Including (I) f/hold land lying to the north and south of hughenden avenue and sports ground at valley rd,high wycombe; t/no BM88010; (ii) f/hold land and buildings to north east of foundry rd,camborne; CL47455; (iii) f/hold land and buildings on the north side of ranelagh rd,ipswich; t/no SK61559; see 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Paircom Finance Limited
    Транзакции
    • 12 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0