CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00981659
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Юридический адрес
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    RENTCO NATIONWIDE LIMITED09 июн. 1970 г.09 июн. 1970 г.

    Каковы последние отчеты CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2016 г.

    Какие последние документы подавались CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    10 страницыLIQ13

    Разное

    Form AD03/historic register/members
    2 страницыMISC

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 страницыAD03

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен на Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 страницыAD02

    Юридический адрес изменен с , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT на 1 More London Place London SE1 2AF 12 янв. 2018 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    4 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 21 дек. 2017 г.

    LRESSP

    Уведомление о Ge Ese Uk Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 06 апр. 2016 г.

    2 страницыPSC02

    Отзыв заявления лица, осуществляющего значительный контроль, 28 дек. 2017 г.

    2 страницыPSC09

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 окт. 2017 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Joseph Preston Swithenbank в качестве директора 11 сент. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Neil Campbell Smith в качестве директора 14 июн. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Jonathan Lawrence John Gatt на должность директора 30 мар. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 окт. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Вторая подача заявления о назначении Neil Smith директором

    6 страницыRP04AP01

    Изменение данных директора для Joseph Preston Swithenbank 31 авг. 2016 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Joseph Preston Swithenbank 31 авг. 2016 г.

    2 страницыCH01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 04 мар. 2016 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Cancellation of captial redemption reserve 19/02/2016
    RES13

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Кто является должностными лицами CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Директор
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomMaltese228824220001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Секретарь
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Секретарь
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Секретарь компании
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Секретарь компании
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь компании
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Директор
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Директор
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Директор
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Директор
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Директор
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Директор
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Директор
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Директор
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Директор
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790002
    FREDHOLM, James William
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    Директор
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    American33092100001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Директор
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Директор
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Директор
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Директор
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Директор
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Директор
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Директор
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Директор
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Директор
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Директор
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Директор
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen183236480004
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Директор компании
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер1329406
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Каковы последние заявления о лицах, осуществляющих значительный контроль над CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
    УведомленПрекращеноЗаявление
    31 окт. 2016 г.01 дек. 2017 г.Компания еще не завершила разумные шаги для выяснения, является ли кто-либо регистрируемым лицом или регистрируемым соответствующим юридическим лицом в отношении компании.

    Есть ли у CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 26 июл. 1996 г.
    Поставлен 30 июл. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Транзакции
    • 30 июл. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мая 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 14 авг. 1995 г.
    Поставлен 01 сент. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    Краткое описание
    The trailers as described in the attached schedule with all accessories,components,parts......etc. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Trinity (Jersey) Limited
    Транзакции
    • 01 сент. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 мая 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 мар. 1994 г.
    Поставлен 21 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Транзакции
    • 21 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 30 сент. 1988 г.
    Поставлен 19 окт. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the first agreements of various dates
    Краткое описание
    All the company's right title & interest in the monies then or thereafterpayable to the company by the sub-leases pursuant to the terms of the sub-lease agreements.
    Уполномоченные лица
    • Mdfc Industrial Finance Limtied.
    Транзакции
    • 19 окт. 1988 г.Регистрация залога
    • 22 июн. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 21 июл. 1988 г.
    Поставлен 11 авг. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Краткое описание
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sub lease agreements (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    Транзакции
    • 11 авг. 1988 г.Регистрация залога
    • 19 июл. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 28 июн. 1988 г.
    Поставлен 18 июл. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the first agreements and under the terms of the c harge.
    Краткое описание
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sublease agreements (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Ball Leasing Limited.
    Транзакции
    • 18 июл. 1988 г.Регистрация залога
    • 22 июн. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 мар. 1988 г.
    Поставлен 07 апр. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Unit 3 badminton court church street amersham buckinghamshire title no. Bm 86544.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 07 апр. 1988 г.Регистрация залога
    • 22 июн. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 22 февр. 1988 г.
    Поставлен 25 февр. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or by virtue of all conditional sale, hire purchase leas ing and/or bailment contracts under the terms of the charge
    Краткое описание
    All the company's rights title and interest in and to all agreements entered into or to be entered into by the company with third parties (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Security Pacific Eurofinance Inc
    Транзакции
    • 25 февр. 1988 г.Регистрация залога
    • 22 июн. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 22 февр. 1988 г.
    Поставлен 25 февр. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents of even date
    Краткое описание
    Floating charge all its undertaking and all property and assets present and future.
    Уполномоченные лица
    • Security Pacific Eurofinance, Inc.
    Транзакции
    • 25 февр. 1988 г.Регистрация залога
    • 07 окт. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 23 дек. 1987 г.
    Поставлен 12 янв. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement and under the terms of the charge
    Краткое описание
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof b etween the company and a person to whom the company lets or agrees to let goods. (For full details see form 395).
    Уполномоченные лица
    • Midland Mortgage Leasing Limited
    Транзакции
    • 12 янв. 1988 г.Регистрация залога
    • 22 июн. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    21 дек. 2017 г.Начало ликвидации
    10 апр. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Практик
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Практик
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0