MARSHELL GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииMARSHELL GROUP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01011142
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель MARSHELL GROUP LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится MARSHELL GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    Ground Floor West
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Essex
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия MARSHELL GROUP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TOBACCO KIOSKS LIMITED14 мая 1971 г.14 мая 1971 г.

    Каковы последние отчеты MARSHELL GROUP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на29 нояб. 2020 г.

    Какие последние документы подавались MARSHELL GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Уведомление о подтверждении, составленное 19 апр. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Предыдущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Назначение Chief Operating Officer Karen Anita Mcewan на должность директора 04 мая 2022 г.

    2 страницыAP01

    Уведомление о подтверждении, составленное 19 апр. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Simon Jonathan Miller в качестве директора 24 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Indigo Corporate Secretary Limited на должность секретаря 14 мар. 2022 г.

    2 страницыAP04

    Прекращение полномочий Rachel Peat в качестве секретаря 14 мар. 2022 г.

    1 страницыTM02

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 19 апр. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Изменение данных о Tm Group Holdings Ltd как лице, осуществляющем значительный контроль, 06 апр. 2016 г.

    2 страницыPSC05

    Изменение данных о Tm Group Holdings Ltd как лице, осуществляющем значительный контроль, 09 дек. 2020 г.

    2 страницыPSC05

    Юридический адрес изменен с Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP United Kingdom на Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QW 09 дек. 2020 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Юридический адрес изменен с Mccoll's House Ashwells Road Brentwood Essex CM15 9st на Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP 10 сент. 2020 г.

    1 страницыAD01

    Назначение Giles Matthew Oliver David на должность директора 09 июл. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Robbie Ian Bell в качестве директора 30 июн. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 19 апр. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Кто является должностными лицами MARSHELL GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер13253973
    281695990002
    BUTLER, Stuart Clive
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Директор
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishFinance Director127794710001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Директор
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer187907210001
    MCEWAN, Karen Anita
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Директор
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer 272054760001
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Секретарь
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    FAIRBAIRN, David William
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Секретарь
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    British35463440001
    GOSNELL, Michael James
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    Секретарь
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    British10496160001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Секретарь
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    PEAT, Rachel
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Секретарь
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    256010520001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Секретарь
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Секретарь
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237929500001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Директор
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector107991420002
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Директор
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    BROWN, Ian
    5 Coldicott Gardens
    Orchard Manor
    WR11 6JW Evesham
    Worcestershire
    Директор
    5 Coldicott Gardens
    Orchard Manor
    WR11 6JW Evesham
    Worcestershire
    BritishManaging Director38866120001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    Директор
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    Директор
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Director36622820001
    BUTLER, Adrian Nickolas
    The Retreat
    Wellmans Meadow
    RG20 5HJ Kingsclere
    Berkshire
    Директор
    The Retreat
    Wellmans Meadow
    RG20 5HJ Kingsclere
    Berkshire
    BritishRetail Director48681750001
    CARPENTER, George Frederick Alfred
    8 Yarrowside
    Little Chalfont
    HP7 9QL Amersham
    Bucks
    Директор
    8 Yarrowside
    Little Chalfont
    HP7 9QL Amersham
    Bucks
    BritishCompany Director7680560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Директор
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Dir31500810002
    CULLENS, Alan
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    Директор
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector6875310002
    FAIRBAIRN, David William
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Директор
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant7680570001
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Директор
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishCfo181763320001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Директор
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector209349290001
    GRIFFITHS, William Trafford
    26 Dove Park
    Chorleywood
    WD3 5NY Rickmansworth
    Hertfordshire
    Директор
    26 Dove Park
    Chorleywood
    WD3 5NY Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director26623510001
    KEEN, David John
    4 Boynton Drive
    Mapperley
    NG3 3EP Nottingham
    Директор
    4 Boynton Drive
    Mapperley
    NG3 3EP Nottingham
    BritishCompany Director56997350001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Директор
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector147052660001
    MILLER, Simon Jonathan
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Директор
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector88269280005
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    Директор
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director6907290001
    PANTO, Ian Michael
    Eversley Park Avenue
    Chorleywood
    WD3 5DU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Директор
    Eversley Park Avenue
    Chorleywood
    WD3 5DU Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director26623520001
    TERRAS, Duncan Crichton
    5 Old Manor Close
    Drayton Bassett
    B78 3UQ Tamworth
    Staffordshire
    Директор
    5 Old Manor Close
    Drayton Bassett
    B78 3UQ Tamworth
    Staffordshire
    BritishDirector43713630003
    THOMSON, Peter Nicholson
    Cranwell Lodge 29 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    Cranwell Lodge 29 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    ScottishRetail Trading Director975790001
    WATERS, Nigel John
    The Retreat
    Stanford Road Swinford
    LE17 6BJ Lutterworth
    Leicestershire
    Директор
    The Retreat
    Stanford Road Swinford
    LE17 6BJ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishDirector39768100001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    Директор
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishDirector101631100002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над MARSHELL GROUP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеEngland
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер03462566
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у MARSHELL GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 17 июл. 2002 г.
    Поставлен 24 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 24 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 окт. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 28 нояб. 1998 г.
    Поставлен 08 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 июн. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 24 июл. 1995 г.
    Поставлен 31 июл. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 31 июл. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 26 сент. 1994 г.
    Поставлен 29 сент. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Краткое описание
    The rent deposit account in respect of the l/h premises k/a concession unit 3 netto foodstore oldfirld lane wortley leeds. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Dansk Supermarkets
    Транзакции
    • 29 сент. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0