SANDTOFT TRADING LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSANDTOFT TRADING LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01094518
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SANDTOFT TRADING LIMITED?

    • Производство кирпичей, плитки и строительных изделий из обожженной глины (23320) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится SANDTOFT TRADING LIMITED?

    Юридический адрес
    Wienerberger House Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Cheshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SANDTOFT TRADING LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SANDTOFT ROOF TILES LIMITED10 июл. 1991 г.10 июл. 1991 г.
    GOXHILL TILERIES LIMITED06 февр. 1973 г.06 февр. 1973 г.

    Каковы последние отчеты SANDTOFT TRADING LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Какие последние документы подавались SANDTOFT TRADING LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницы4.71

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 01 сент. 2015 г.

    LRESSP

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    Назначение Mr Harald Anton Schwarzmayr на должность директора 26 авг. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Nicholas James Oldridge в качестве директора 09 янв. 2015 г.

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Martin Henry Oldridge в качестве директора 08 янв. 2015 г.

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Simon Dominic Sinclair Oldridge в качестве директора 09 янв. 2015 г.

    2 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital14 янв. 2015 г.

    Отчет о капитале на 14 янв. 2015 г.

    • Капитал: GBP 1,000
    SH01

    Полное погашение обременения 7

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 2

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 3

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 8

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 9

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 4

    2 страницыMR04

    Прекращение полномочий Bert Jan Koekoek в качестве директора 26 авг. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Michael Grace на должность секретаря

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Kaye Few в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    8 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital17 дек. 2013 г.

    Отчет о капитале на 17 дек. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1,000
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    Кто является должностными лицами SANDTOFT TRADING LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GRACE, Michael
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    Секретарь
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    188991590001
    SCHWARZMAYR, Harald Anton
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    Директор
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United KingdomAustrian103815020002
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Директор
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113293590001
    CUSK, Katherine Abigail
    279a High Street
    Boston Spa
    LS23 6AL Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    279a High Street
    Boston Spa
    LS23 6AL Leeds
    West Yorkshire
    British100123400002
    FEW, Kaye Suzanne
    Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    14
    Cheshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    14
    Cheshire
    United Kingdom
    152224780001
    OLDRIDGE, Simon Dominic Sinclair
    Highfield
    Old Park Road Roundhay
    LS8 1JX Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    Highfield
    Old Park Road Roundhay
    LS8 1JX Leeds
    West Yorkshire
    British69510150002
    PINCHBECK, Christopher
    76 Laceby Road
    DN34 5BJ Grimsby
    South Humberside
    Секретарь
    76 Laceby Road
    DN34 5BJ Grimsby
    South Humberside
    British69510050001
    WAITE, Eric
    8 Roundwood Road
    Baildon
    BD17 7JZ Shipley
    West Yorkshire
    Секретарь
    8 Roundwood Road
    Baildon
    BD17 7JZ Shipley
    West Yorkshire
    British7980100003
    BARTLE, John
    Mill Road
    Crowle
    DN17 4LW Scunthorpe
    63
    North Lincolnshire
    England
    Директор
    Mill Road
    Crowle
    DN17 4LW Scunthorpe
    63
    North Lincolnshire
    England
    British129311500001
    BARTLE, John
    Mill Road
    Crowle
    DN17 4LW Scunthorpe
    63
    North Lincolnshire
    England
    Директор
    Mill Road
    Crowle
    DN17 4LW Scunthorpe
    63
    North Lincolnshire
    England
    British129311500001
    CUSK, Katherine Abigail
    279a High Street
    Boston Spa
    LS23 6AL Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    279a High Street
    Boston Spa
    LS23 6AL Leeds
    West Yorkshire
    British100123400002
    DUDDING, John William
    Wayside Carr Lane
    Broomfleet
    HU15 1RH Brough
    North Humberside
    Директор
    Wayside Carr Lane
    Broomfleet
    HU15 1RH Brough
    North Humberside
    British43260310001
    DUDDING, John William
    Wayside Carr Lane
    Broomfleet
    HU15 1RH Brough
    North Humberside
    Директор
    Wayside Carr Lane
    Broomfleet
    HU15 1RH Brough
    North Humberside
    British43260310001
    EADLINGTON, Victoria Michelle Sinclair
    Horsewells Farm Horsewell Street
    Gringley On The Hill
    DN22 9AQ Doncaster
    South Yorkshire
    Директор
    Horsewells Farm Horsewell Street
    Gringley On The Hill
    DN22 9AQ Doncaster
    South Yorkshire
    British90047640001
    GOODWIN, Carole Lesley
    22 Main Road
    S21 3UT Renishaw
    North East Derbyshire
    Директор
    22 Main Road
    S21 3UT Renishaw
    North East Derbyshire
    United KingdomBritish116031480001
    KOEKOEK, Bert Jan
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    Директор
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    NetherlandsDutch119912460001
    OLDRIDGE, Christopher Frederick
    Chestnuts
    Elm Road Waltham
    DN37 0HR Grimsby
    South Humberside
    Директор
    Chestnuts
    Elm Road Waltham
    DN37 0HR Grimsby
    South Humberside
    British7979570001
    OLDRIDGE, Janet
    Orchard Croft St Peters Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Директор
    Orchard Croft St Peters Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    British58065280002
    OLDRIDGE, Julia Abigail
    Bardney Hall
    DN18 5DF Barton On Humber
    South Humberside
    Директор
    Bardney Hall
    DN18 5DF Barton On Humber
    South Humberside
    British7979580001
    OLDRIDGE, Martin Henry
    Old Vicarage Church Causeway
    Thorp Arch
    LS23 7AE Wetherby
    West Yorkshire
    Директор
    Old Vicarage Church Causeway
    Thorp Arch
    LS23 7AE Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish7979590001
    OLDRIDGE, Neville William Sinclair
    Orchard Croft
    Saint Peters Lane, Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Директор
    Orchard Croft
    Saint Peters Lane, Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    British7979600003
    OLDRIDGE, Nicholas James
    11 Gledhow Lane
    Roundhay
    LS8 1RT Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    11 Gledhow Lane
    Roundhay
    LS8 1RT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish63463570004
    OLDRIDGE, Richard Alexander
    10 New Street
    Elsham
    DN20 0RW Brigg
    North Lincolnshire
    Директор
    10 New Street
    Elsham
    DN20 0RW Brigg
    North Lincolnshire
    British7979610004
    OLDRIDGE, Simon Dominic Sinclair
    Highfield
    Old Park Road Roundhay
    LS8 1JX Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    Highfield
    Old Park Road Roundhay
    LS8 1JX Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish69510150002
    PINCHBECK, Christopher
    76 Laceby Road
    DN34 5BJ Grimsby
    South Humberside
    Директор
    76 Laceby Road
    DN34 5BJ Grimsby
    South Humberside
    British69510050001
    WAITE, Eric
    8 Roundwood Road
    Baildon
    BD17 7JZ Shipley
    West Yorkshire
    Директор
    8 Roundwood Road
    Baildon
    BD17 7JZ Shipley
    West Yorkshire
    British7980100003
    WATSON, Richard Baillie
    Clovelly Wold Road
    DN19 7BT Barrow Upon Humber
    South Humberside
    Директор
    Clovelly Wold Road
    DN19 7BT Barrow Upon Humber
    South Humberside
    British43260300001

    Есть ли у SANDTOFT TRADING LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Chattels mortgage
    Создан 21 сент. 2007 г.
    Поставлен 27 сент. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof being 4 x linde H25D engine counterbalanced trucks,s/no's H2X351NO2497,H2X351NO2499,H2X392UO1636,H2X392UO1630 portasilo ggbs raw materials silo s/no G8346.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 27 сент. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Chattels mortgage
    Создан 25 июн. 2007 г.
    Поставлен 26 июн. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Extensions and developments to the existing tile production plant and machinery in factories 1 and 2 at broomfleet summarised as: old english moulds project reference DR64 at a capital cost of £105,107.00 and including rieter werke moulds referee 35 50099 and base plates reference 42 50 009/50 028 for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 26 июн. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Chattels mortgage
    Создан 08 февр. 2007 г.
    Поставлен 09 февр. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Cep 23/2006 project at a capital cost of £12,071.05: robatech UK hot melt application equipment, concept b 5/4 KPC12 c/w CLSIK48 s/no 20060703/0720, cep 08/2006 project at a capital cost of £12,640.70: nordson premium ridge adhesive equipment s/nos SAO5J22414, TAO6A1822/1827, SAO6A98749/98, AN06A00689, AN05M00508, cep 40/2006 project at a capital cost of £239,255.68: hand made production area equipment including reiter screen feeder type sr 1500 s/no 400-06-M05060 for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 09 февр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Создан 12 янв. 2007 г.
    Поставлен 16 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Транзакции
    • 16 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Chattels mortgage
    Создан 21 окт. 2005 г.
    Поставлен 22 окт. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Drying tray circuit main line, tunnel dryer main line, including prefabricated structure, ventilation, ducts, burners, dryer cars (34), trays (19 584), power cabinets, PLC, wiring for further details of the items of plant charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited, Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 22 окт. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Chattels mortgage
    Создан 11 окт. 2004 г.
    Поставлен 12 окт. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the form 395 or any part thereof comprising clay preparation plant broomfleet no 1 dr-6/1 line broomfleet no 1 specials fittings broomfleet no 1 dr-6/iv line. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited & Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 12 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 10 сент. 2004 г.
    Поставлен 15 сент. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 15 сент. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 10 сент. 2004 г.
    Поставлен 15 сент. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 15 сент. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 12 мая 2003 г.
    Поставлен 14 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 14 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у SANDTOFT TRADING LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    01 сент. 2015 г.Начало ликвидации
    04 февр. 2017 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Практик
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0