TURBINE BLADING LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTURBINE BLADING LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01265008
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TURBINE BLADING LIMITED?

    • Механическая обработка (25620) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится TURBINE BLADING LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты TURBINE BLADING LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2015 г.

    Какие последние документы подавались TURBINE BLADING LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    12 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 02 апр. 2021 г.

    10 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 02 апр. 2020 г.

    10 страницыLIQ03

    Полное погашение обременения 18

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 17

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 14

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 16

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 15

    1 страницыMR04

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 02 апр. 2019 г.

    9 страницыLIQ03

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Юридический адрес изменен с The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU на 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR 26 апр. 2018 г.

    2 страницыAD01

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 03 апр. 2018 г.

    LRESSP

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 страницыAD03

    Уведомление о Ge Inspection and Repair Services Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 06 апр. 2016 г.

    2 страницыPSC02

    Отзыв заявления лица, осуществляющего значительный контроль, 29 дек. 2017 г.

    2 страницыPSC09

    Уведомление о подтверждении, составленное 15 окт. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Решения

    Resolutions
    15 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    resolution

    Решение о капитализации или эмиссии бонусных акций

    That the sum of £1,196,177.00 being the total amount standing to the credit of the company's other reserves, be and is hereby capitalised and appropriated as capital to the holders of the ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 21/09/2017
    RES14
    capital

    Решение о размещении ценных бумаг

    RES10

    legacy

    2 страницыSH20

    Отчет о капитале на 27 сент. 2017 г.

    • Капитал: GBP 1
    3 страницыSH19

    legacy

    2 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Cancellation of share premium account 22/09/2017
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Отчет о капитале после размещения акций 21 сент. 2017 г.

    • Капитал: GBP 1,208,477
    3 страницыSH01

    Кто является должностными лицами TURBINE BLADING LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер7038430
    146358090001
    DOWNEY, Stephen Thomas
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Operation Manager184747430001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    CATALDO, John
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    Секретарь
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    British62465990001
    JAFFA, Richard Henry
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    English9163880001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Секретарь компании
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Секретарь компании
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    BREMNER, Ian Miller
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    Директор
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant29995610001
    CARTLEDGE, Andrew
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    Директор
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    BritishDirector70072110003
    CHRISTIE, Roderick Angus
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    Директор
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager Energy Service82543780001
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Counsel56868460002
    COYLE, Feilim Malachy
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    Директор
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    IrishDirector70072140002
    DANIELL, Paul Nigel
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    BritishHuman Resources Manager62463920001
    DIGBY, Mark Damien
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Директор
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    IrishEurope Operations Manager103125610001
    FENECH, Lindy Frances
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    Директор
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone172863970001
    FRASER, Gillian Annette
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector30720040001
    FRASER, Michael James
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector35575120001
    GAULT, Ernest Harold
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    Директор
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    AmericanCompany Director62463900001
    GRIFFITHS, Kyle
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomUs CitizenOperations Executive172602560001
    JORDAN, Stephen John
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    Директор
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    BritishCompany Director32376290001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Директор
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    BritishUk Controller Ge Energy106985300001
    LEVITCH, Paul Edward
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Директор
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishSales Director50792110001
    MULHOLLAND, Diarmaid Patrick
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    ItalyIrishSales Engineer116288460001
    PARKES, David John William
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    Директор
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    BritishAccountant85953530001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritishCfo Europe203364460001
    TON, Gwaine William
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    Директор
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    AmericanCompany Director93302530001
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager96648390001
    WARDLE, John Malcolm
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    Директор
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    BritishDirector5096040001
    WHITE, Andrew Christopher
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    Директор
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    BritishGeneral Manager62466070001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над TURBINE BLADING LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер1182449
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Каковы последние заявления о лицах, осуществляющих значительный контроль над TURBINE BLADING LIMITED?

    Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
    УведомленПрекращеноЗаявление
    15 окт. 2016 г.01 дек. 2017 г.Компания еще не завершила разумные шаги для выяснения, является ли кто-либо регистрируемым лицом или регистрируемым соответствующим юридическим лицом в отношении компании.

    Есть ли у TURBINE BLADING LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 26 февр. 1998 г.
    Поставлен 04 мар. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 04 мар. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 24 янв. 1997 г.
    Поставлен 29 янв. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Car park and adjoining land at station rd,shipston-on-stour warwickshire with all rights,licences,guarantees,rent deposits contracts,undertakings,goodwill of business and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 29 янв. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 18 дек. 1996 г.
    Поставлен 24 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Station road, shipston-on-stour warwickshire; any goodwill of any business from time to time carried on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 24 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 18 дек. 1996 г.
    Поставлен 19 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Property at berry hill industrial estate droitwich with the benefit of all rights and licences shares or membership rights goodwill of any business rental and other money payable.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 19 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating charge
    Создан 03 дек. 1996 г.
    Поставлен 07 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 07 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 сент. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Chattel mortgage
    Создан 15 мар. 1993 г.
    Поставлен 25 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Heller horizontal - PFH10 - M39498 (for full details of charge see form 395).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 25 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 06 июл. 1992 г.
    Поставлен 15 июл. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Various chattels (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 15 июл. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 авг. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 01 июл. 1991 г.
    Поставлен 10 июл. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatsoever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 10 июл. 1991 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 20 июн. 1991 г.
    Поставлен 10 июл. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Piece of land near station road, shipston-on-stour, in the county of warwickshire.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 10 июл. 1991 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge.
    Создан 12 окт. 1989 г.
    Поставлен 31 окт. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited uum al - jawaby no.2.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 31 окт. 1989 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 12 окт. 1989 г.
    Поставлен 31 окт. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited egat.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 31 окт. 1989 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 12 сент. 1989 г.
    Поставлен 02 окт. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account. Of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited uum al jawaby.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 02 окт. 1989 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 08 февр. 1989 г.
    Поставлен 22 февр. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 22 февр. 1989 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 18 авг. 1986 г.
    Поставлен 26 авг. 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Various machinery (see continuation sheet NO1. Attached to doc 395).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 26 авг. 1986 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 22 июл. 1986 г.
    Поставлен 28 июл. 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Mandelli machining centre serial no. 7239.81.07000049. (see doc M14 for futher details and attached continuation sheet no 1 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 28 июл. 1986 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 22 июл. 1986 г.
    Поставлен 28 июл. 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Mitutoyo coordinate measurer with attachments serial no. Cmm-B241-6002 hp 9816. mandelli machining centre (HP9872 plotter 7289/83/07000067) (see doc M13 for further details).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 28 июл. 1986 г.Регистрация залога
    • 16 окт. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 02 мая 1986 г.
    Поставлен 12 мая 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Dale cross grange. Mearse lane, barnt green, bromsgrove, hereford & worcester. Title no. Hw 17903.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 мая 1986 г.Регистрация залога
    • 19 авг. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 29 июн. 1978 г.
    Поставлен 05 июл. 1978 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 05 июл. 1978 г.Регистрация залога
    • 26 февр. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у TURBINE BLADING LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    03 апр. 2018 г.Начало ликвидации
    06 июл. 2022 г.Дата планируемой ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0