CMS BUILDING SERVICES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCMS BUILDING SERVICES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01299640
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    • Электромонтажные работы (43210) / Строительство

    Где находится CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Юридический адрес
    2nd Floor 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    COMBINED MECHANICAL SERVICES (ELECTRICAL) LIMITED22 февр. 1977 г.22 февр. 1977 г.

    Каковы последние отчеты CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2012 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2013 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2011 г.

    Какие последние документы подавались CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    11 страницы4.72

    Юридический адрес изменен с , 122 Widney Road, Bentley Heath, Solihull, B93 3BL на 2nd Floor 40 Queen Square Bristol BS1 4QP 03 нояб. 2016 г.

    2 страницыAD01

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 февр. 2016 г.

    12 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 февр. 2015 г.

    12 страницы4.68

    Юридический адрес изменен с , the Grange 26 Market Square, Westerham, Kent, TN16 1HB, United Kingdom 04 мар. 2014 г.

    2 страницыAD01

    Отчет о состоянии дел с приложенной формой 4.19

    14 страницы4.20

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации

    LRESEX

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Прекращение полномочий Avtar Sandhu в качестве директора

    1 страницыTM01

    Регистрация обременения 012996400008

    21 страницыMR01

    Юридический адрес изменен с , 30 st. Dunstans Hill, Sutton, Surrey, SM1 2UD, United Kingdom 19 мар. 2013 г.

    1 страницыAD01

    Уведомление регистратору компаний о вступлении в силу добровольного соглашения

    6 страницы1.1

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital23 янв. 2013 г.

    Отчет о капитале на 23 янв. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1,000
    SH01

    Юридический адрес изменен с , Unit 8 Long Acre Trading Estate, Long Acre Aston, Birmingham, West Midlands, B7 5JD, United Kingdom 23 янв. 2013 г.

    1 страницыAD01

    legacy

    5 страницыMG01

    Прекращение полномочий Sean O'neill в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Avtar Singh Sandhu на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Sean Patrick O'neill на должность директора

    2 страницыAP01

    Юридический адрес изменен с , 591 London Road, North Cheam, Surrey, SM3 9AG, England 26 июн. 2012 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    legacy

    3 страницыMG02

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01

    Скорректированная бухгалтерская отчетность

    7 страницыAAMD

    Юридический адрес изменен с , 7 - 9, the Avenue, Eastbourne, East Sussex, BN21 3YA, United Kingdom 06 мая 2011 г.

    1 страницыAD01

    Кто является должностными лицами CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    OSBORNE, Raymond Thomas
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    United Kingdom
    Директор
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81964490002
    CHARLTON, Christopher Robert
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector55853000005
    DOPSON, Barry
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    Секретарь
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    British23336930004
    MACKENZIE, Jeremy
    14 Northend
    Batheaston
    BA1 7EN Bath
    Avon
    Секретарь
    14 Northend
    Batheaston
    BA1 7EN Bath
    Avon
    British100984090001
    MASLIN, Roland Stephen
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    New ZealandAccountant11901760001
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Секретарь
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    British100942650001
    CHARLTON, Benjamin James Robert
    Flat 11 18 Egerton Gardens
    SW3 2DG London
    Директор
    Flat 11 18 Egerton Gardens
    SW3 2DG London
    EnglandBritishCorporate Director103208830001
    CHARLTON, Christopher Robert
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    Директор
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector55853000005
    DALTON, John Charles
    Vale House Chess Hill
    Loudwater
    WD3 4HU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Директор
    Vale House Chess Hill
    Loudwater
    WD3 4HU Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant7382690001
    DEXTER, Lee
    Morgan Ryse
    Oldbury Wells
    WV16 5JE Bridgnorth
    Shropshire
    Директор
    Morgan Ryse
    Oldbury Wells
    WV16 5JE Bridgnorth
    Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director94290580001
    DOPSON, Barry
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    Директор
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    BritishEngineer23336930004
    HANDFORD, Mark Adam
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    Директор
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    EnglandBritishEngineer154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Директор
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Директор
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishElectronic Eng154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Директор
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer154608220001
    LANHAM, Hugh Christopher
    October Lodge
    Fakenham Road
    NR21 7AW Great Ryburgh
    Norfolk
    Директор
    October Lodge
    Fakenham Road
    NR21 7AW Great Ryburgh
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant111108710001
    MASLIN, Roland Stephen
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomNew ZealandAccountant11901760001
    MCLEOD, Alexander George Albert
    Longhouse
    Arkley Lane
    EN5 3JR Barnet
    Hertfordshire
    Директор
    Longhouse
    Arkley Lane
    EN5 3JR Barnet
    Hertfordshire
    BritishDirector91173520001
    O'NEILL, Sean Patrick
    Long Acre Trading Estate
    Long Acre Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8
    West Midlands
    United Kingdom
    Директор
    Long Acre Trading Estate
    Long Acre Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director104776410002
    OSBORNE, Raymond Thomas
    28 Raleigh Close
    ME5 7SB Chatham
    Kent
    Директор
    28 Raleigh Close
    ME5 7SB Chatham
    Kent
    United KingdomBritishEngineer81964490002
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Директор
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    BritishElectrical Eng100942650001
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Директор
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    BritishEngineer100942650001
    RODGER, Thomas John
    29 Wilkinson Place
    OX28 6JT Witney
    Oxfordshire
    Директор
    29 Wilkinson Place
    OX28 6JT Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector20948660002
    SANDHU, Avtar Singh
    Long Acre
    Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8 Long Acre Trading Estate
    West Midlands
    United Kingdom
    Директор
    Long Acre
    Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8 Long Acre Trading Estate
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director159477460001

    Есть ли у CMS BUILDING SERVICES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 06 июн. 2013 г.
    Поставлен 15 июн. 2013 г.
    Не погашен
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Транзакции
    • 15 июн. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    Deed of assignment
    Создан 24 дек. 2012 г.
    Поставлен 12 янв. 2013 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The receivables, together with all rights, benefits, interest, insurance monies or proceeds arising under or pursuant thereto see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Транзакции
    • 12 янв. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 22 сент. 2006 г.
    Поставлен 28 сент. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 28 сент. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 авг. 2010 г.Заявление, что часть или все имущество, обремененное залогом, освобождено (MG04)
    • 12 мая 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 11 сент. 2006 г.
    Поставлен 13 сент. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Property k/a 3A the parade oldfields road sutton t/no SGL79625. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 13 сент. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 сент. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 18 апр. 2006 г.
    Поставлен 19 апр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Транзакции
    • 19 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 окт. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 19 дек. 2005 г.
    Поставлен 04 янв. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company formerly known as combined mechanical services (electrical) limited to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    3A the parade oldfield road sutton surrey t/no SGL79625. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 04 янв. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 10 авг. 2004 г.
    Поставлен 18 авг. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 авг. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 дек. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Создан 15 дек. 1998 г.
    Поставлен 23 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Account no 70046671. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 23 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 нояб. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у CMS BUILDING SERVICES LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    28 февр. 2013 г.Дата собрания для утверждения CVA
    Добровольное соглашение с кредиторами (CVA)
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Duncan Roderick Morris
    Elta House Birmingham Road
    CV37 0AQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Практик
    Elta House Birmingham Road
    CV37 0AQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    2
    ДатаТип
    07 мая 2017 г.Дата ликвидации
    26 февр. 2014 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Colin Andrew Prescott
    Leonard Curtis Recovery 2nd Floor, 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Практик
    Leonard Curtis Recovery 2nd Floor, 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Alan Clifton
    Po Box
    16114
    B93 3GS Solihull
    Практик
    Po Box
    16114
    B93 3GS Solihull

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0