SHIELDTECH PLC

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSHIELDTECH PLC
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаПубличная акционерная компания
    Номер компании 01423125
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SHIELDTECH PLC?

    • (7415) /

    Где находится SHIELDTECH PLC?

    Юридический адрес
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SHIELDTECH PLC?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BASE GROUP PLC27 июн. 2002 г.27 июн. 2002 г.
    DIGITAL SPORT PLC29 нояб. 2000 г.29 нояб. 2000 г.
    FERRUM HOLDINGS PLC24 нояб. 1989 г.24 нояб. 1989 г.
    FLOYD ENERGY PLC16 мая 1988 г.16 мая 1988 г.
    FLOYD OIL PARTICIPATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY25 мая 1979 г.25 мая 1979 г.

    Каковы последние отчеты SHIELDTECH PLC?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2009 г.

    Какие последние документы подавались SHIELDTECH PLC?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Отчет о ходе администрации до 20 апр. 2011 г.

    18 страницы2.24B

    Уведомление о переходе от администрации к роспуску от 20 апр. 2011 г.

    17 страницы2.35B

    Прекращение полномочий Pommy Sarwal в качестве директора

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Paul Grundy в качестве секретаря

    2 страницыTM02

    Прекращение полномочий Paul Grundy в качестве директора

    2 страницыTM01

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.15B/2.14B

    9 страницы2.16B

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    2 страницыF2.18

    Заявление о предложениях администратора

    42 страницы2.17B

    Юридический адрес изменен с Unit 5 Chesford Grange Woolston Warrington WA1 4RQ United Kingdom 04 нояб. 2010 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    Годовой отчет с массовым списком акционеров

    18 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital09 авг. 2010 г.

    Отчет о капитале на 09 авг. 2010 г.

    • Капитал: GBP 9,009,694
    SH01

    Прекращение полномочий Robert Denton в качестве директора

    1 страницыTM01

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о размещении ценных бумаг

    RES10

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    46 страницыAA

    Прекращение полномочий Robert Denton в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Назначение Mr Paul Grundy на должность секретаря

    1 страницыAP03

    Назначение Mr Paul Grundy на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Robert Denton в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    legacy

    1 страницы288a

    Решения

    Resolutions
    68 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Appointing as a director/investment the circular 22/06/2009
    RES13
    capital

    Решение о размещении ценных бумаг

    RES10
    capital

    Решение об отмене преимущественного права

    RES11
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    legacy

    7 страницы395

    legacy

    1 страницы287

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    4 страницы395

    Кто является должностными лицами SHIELDTECH PLC?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    O`NEILL, Anthony Arthur
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Директор
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British58776190001
    POVEY, Keith, Sir
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    Директор
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    British123375790001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Директор
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish8610650001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Секретарь
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    British250279270001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Секретарь
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    145996590001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Секретарь
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    British128648070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Секретарь
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Секретарь компании
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    AITKEN, Robin Douglas
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    Директор
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    British62740310002
    AKERS, John Michael Anthony
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    Директор
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritish17792380001
    ANGEL, Leon
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    Директор
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    British14283520001
    BAARTMANS, Kees-Jan
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Директор
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Dutch28166930001
    BARKER, Crispin Jonathan
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    Директор
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    British23728980001
    BRADSHAW, Adrian Effland
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    Директор
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish74991310001
    BRIDGE, Peter John
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    Директор
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    United KingdomBritish54098960002
    CARTER, John Henry
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Директор
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British15186400001
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Директор
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Директор
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish250279270001
    FRIER, Gavin Austin
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    Директор
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    British692610004
    GARNER, Marshall Kenneth
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    Директор
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish52313820002
    GOURLAY, John Malcolm
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    Директор
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    British574590001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Директор
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    HATTON, John Leonard
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    Директор
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    British17792410001
    HOPKINSON, Glenn
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    Директор
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish76865910002
    HORNER, Rupert Howard Milton
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Директор
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish42919770001
    HUME, James Douglas Howden
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    Директор
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    British738610001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Директор
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    United KingdomBritish128648070001
    KENNEDY, Simon Mark
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    Директор
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    British60141130001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Директор
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    LENSEN, John
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Директор
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Dutch38326960001
    MCCAUGHEY, Paul Trevor
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    Директор
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    British76385200002
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Директор
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritish176036600001
    ROUND, Richard Calvin
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    Директор
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    British108158250001
    SARWAL, Pommy Prodaman Kumar
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Директор
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritish103609350001
    SMITH, Gary
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    Директор
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish94244890001

    Есть ли у SHIELDTECH PLC какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 24 июн. 2009 г.
    Поставлен 01 июл. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bruce Gordan Stephen Jenkins and Derek James
    Транзакции
    • 01 июл. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 24 июн. 2009 г.
    Поставлен 25 июн. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 25 июн. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 21 дек. 2007 г.
    Поставлен 08 янв. 2008 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 08 янв. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    Legal mortgage
    Создан 25 июл. 1997 г.
    Поставлен 13 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property known as mech tool housemains works whessoe road darlington county durham title number DU14506 and DU18947. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 13 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 25 июл. 1997 г.
    Поставлен 07 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property as fabrication shop situate at riverview industrial estate off dodsworth street darlington durham title numbers DU160790 DU160904 DU181997 and DU126993. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 07 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 25 июл. 1997 г.
    Поставлен 06 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 06 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 нояб. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 24 дек. 1993 г.
    Поставлен 08 янв. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as amended
    Краткое описание
    The tenants interest uder a lease between london & edinburgh trust (scotland) limited and the cmpany dated 13/3/and 29/4/92. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 янв. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 24 дек. 1993 г.
    Поставлен 08 янв. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as may be amended
    Краткое описание
    The tenants interest in a lease between the city of aberdeen district council and offshore drilling supplies. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 янв. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    Legal mortgage
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a land and buildings on the east side of hoylake road bottesford humberside glanford t/no HS185215 with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a west side of rotherham road rotherham south yorkshire t/no syk 251481 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of park lane basford nottingham nottinghamshire t/nos NT285394 and NT211704 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of whessoe road darlington durham t/no DU14506 DU18947 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business the full benefitof all licences and together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 03 дек. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a river view industrial estate dodsworth street darlington durham t/no's du 181997 DU160904 DU160790 DU126993 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit f all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 30 нояб. 1993 г.
    Поставлен 13 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Краткое описание
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian together with the buildings and other erections thereon k/a 57 melville street. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 13 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 30 нояб. 1993 г.
    Поставлен 13 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under theterms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Краткое описание
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 13 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 24 нояб. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 as amended from time to time in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Краткое описание
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescent east tullos industrial aberdeen in the city of aberdeen extending to 3.45 acres or thereby.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 нояб. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    • 27 мая 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 24 нояб. 1993 г.
    Поставлен 09 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Краткое описание
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescnt east tullos industrial estate aberdeen in the city of aberdeen and county foresaid extending to 3.45 acres or thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 нояб. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    • 27 июн. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 06 авг. 1993 г.
    Поставлен 17 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property on north east side of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 сент. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 29 июл. 1993 г.
    Поставлен 10 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Краткое описание
    F/H land on west of park lane new basford nottingham part t/n nt 285394.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 10 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 сент. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 29 июл. 1993 г.
    Поставлен 10 авг. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Краткое описание
    F/H land on north east of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 10 авг. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 сент. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 01 июл. 1993 г.
    Поставлен 15 июл. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 15 июл. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 янв. 1994 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 28 сент. 1995 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 29 сент. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 01 июл. 1993 г.
    Поставлен 15 июл. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 15 июл. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 янв. 1994 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 28 сент. 1995 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 29 сент. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у SHIELDTECH PLC какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    20 окт. 2010 г.Начало управления
    20 апр. 2011 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Практик
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Практик
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0