ZEALCASTLE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииZEALCASTLE LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01551710
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ZEALCASTLE LIMITED?

    • (7499) /

    Где находится ZEALCASTLE LIMITED?

    Юридический адрес
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты ZEALCASTLE LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2010 г.

    Какие последние документы подавались ZEALCASTLE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Отчет о капитале на 03 февр. 2012 г.

    • Капитал: USD 100.00
    • Капитал: GBP 0.10000
    6 страницыSH19

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Решения

    Resolutions
    4 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Прекращение полномочий Patrick Gallagher в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Clive Adrian Roynon Jennings на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Отставка аудитора

    3 страницыAUD

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Изменение данных секретаря для Miss Frances Bingham 01 мар. 2010 г.

    1 страницыCH03

    Изменение данных директора для Mr Michael Ian Burke 28 янв. 2010 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Michael Ian Burke 28 янв. 2010 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерская отчетность

    4 страницыAA

    legacy

    4 страницы363a

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    1 страницы288c

    Бухгалтерская отчетность

    4 страницыAA

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Кто является должностными лицами ZEALCASTLE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BINGHAM, Frances
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Секретарь
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Other130557520001
    BURKE, Michael Ian
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director148846850001
    JENNINGS, Clive Adrian Roynon
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant79719890001
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Секретарь
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980002
    DUFFILL, Clare Marianne
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    Секретарь
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    BritishChartered Secretary71005690004
    KEMP, Peter Evelyn
    35 Garlichill Road
    KT18 5TZ Epsom
    Surrey
    Секретарь
    35 Garlichill Road
    KT18 5TZ Epsom
    Surrey
    British31932620001
    TALBOT, Richard Ian
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    Секретарь
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    British15269400002
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Секретарь
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    ANDREWS, Gareth Lewis
    4 Saint Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    Директор
    4 Saint Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    United KingdomBritishCasinos Director64255870002
    BARRETT, Glyn Keir Pond
    47 Shirley Drive
    BN3 6UB Hove
    East Sussex
    Директор
    47 Shirley Drive
    BN3 6UB Hove
    East Sussex
    BritishClub Director30328460002
    BODEN, David
    Marlborough House
    5 Thorn Grove
    CM23 5LB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Директор
    Marlborough House
    5 Thorn Grove
    CM23 5LB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director26352200004
    BREATHWICK, Leslie
    The Old Farmhouse Mayns Lane
    Burton Overy
    LE8 9DP Leicester
    Директор
    The Old Farmhouse Mayns Lane
    Burton Overy
    LE8 9DP Leicester
    BritishChartered Accountant41606000003
    BUTLER, Anthony Frederick
    45 Woodstock Grove
    Sherherd's Bush
    W12 8LG London
    Директор
    45 Woodstock Grove
    Sherherd's Bush
    W12 8LG London
    BritishClub Director60719950001
    BYRNE, Peter
    Timbers 6 Upper Park Road
    GU15 2ES Camberley
    Surrey
    Директор
    Timbers 6 Upper Park Road
    GU15 2ES Camberley
    Surrey
    BritishOperations Director26042760001
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Директор
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980002
    GALLAGHER, Patrick James
    Thameside
    RG9 2LJ Henley On Thames
    22
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Thameside
    RG9 2LJ Henley On Thames
    22
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant77355310003
    GILL, Peter Richard
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    Директор
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35996320004
    GOODENOUGH, Alan Leslie
    Redwood House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    Директор
    Redwood House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    BritishChief Executive Officer33114900003
    HAMBLIN, Jonathan Robert
    The Old School House 1 Carlton Road
    Wilbarston
    LE16 8QD Market Harborough
    Leicestershire
    Директор
    The Old School House 1 Carlton Road
    Wilbarston
    LE16 8QD Market Harborough
    Leicestershire
    BritishDirector4838310001
    HAMBUN, Andrew David
    3a The Cloisters
    Walnut Tree Farm Kings Meadow Lane
    NN8 9SE Higham Ferrers
    Northamptonshire
    Директор
    3a The Cloisters
    Walnut Tree Farm Kings Meadow Lane
    NN8 9SE Higham Ferrers
    Northamptonshire
    BritishDirector31932640001
    HARDY, George Barry Conyers
    21 Fallows Green
    AL5 4DH Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    21 Fallows Green
    AL5 4DH Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChief Operating Officer38430001
    HAYWARD, Patrick Henry
    The Kingfishers 120 Harpenden Road
    AL3 6BZ St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    The Kingfishers 120 Harpenden Road
    AL3 6BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director191152580001
    HODGSON, Tom
    54 Plymouth Wharf
    Saundersness Road Isle Of Dogs
    E14 9EL London
    Директор
    54 Plymouth Wharf
    Saundersness Road Isle Of Dogs
    E14 9EL London
    BritishCompliance Director6616130001
    LILLIS, Linda Mary
    39 Dundee Wharf
    Three Colt Street
    E14 8AX London
    Директор
    39 Dundee Wharf
    Three Colt Street
    E14 8AX London
    BritishFinance Director43068050003
    MILLER, Colin David
    2 Chess Close
    Parkfield
    HP5 1UU Latimer
    Buckinghamshire
    Директор
    2 Chess Close
    Parkfield
    HP5 1UU Latimer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishClub Director180550620001
    MOLE, Richard Adrian
    8 Freelands Road
    BR1 3AQ Bromley
    Kent
    Директор
    8 Freelands Road
    BR1 3AQ Bromley
    Kent
    BritishCompany Director6616140001
    RAHA, Maryse
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    Директор
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    FrenchCasinos Director24036050001
    RAMM, Roy Alfred Charles
    Drey 2 Lindsey Way
    RM11 2ED Hornchurch
    Essex
    Директор
    Drey 2 Lindsey Way
    RM11 2ED Hornchurch
    Essex
    BritishCompany Director50321430001
    SHAW, Anthony Brian
    101 Knightsbridge
    SW1X 7RN London
    Директор
    101 Knightsbridge
    SW1X 7RN London
    BritishCasino Manager31932630002
    SMITH, Terrence Kevin
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    Директор
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Accountant30640310001
    WALCOTT, David
    11 Corsell House,
    Tallow Road,
    TW8 8EE Brentford
    Middlesex
    Директор
    11 Corsell House,
    Tallow Road,
    TW8 8EE Brentford
    Middlesex
    BritishFinance Director66583390004

    Есть ли у ZEALCASTLE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of variation
    Создан 19 июн. 1996 г.
    Поставлен 21 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    And for varying the terms of a supplemental mortgage debenture dated 21/11/95
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 21 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 окт. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental mortgage debenture
    Создан 21 нояб. 1995 г.
    Поставлен 11 дек. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facilities agreement,the overdraft letter and this deed as defined therein
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandeficiaries (As Defined Therein)in Its Capacity as Agent and Trustee for the Ben
    Транзакции
    • 11 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 окт. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 26 июн. 1991 г.
    Поставлен 04 июл. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property comprising ground floor and mezzanine floor premises k/as the canadian suite of the park tower hotel knightsbridge london SW1 see form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • Natwest Investment Bank Limited
    Транзакции
    • 04 июл. 1991 г.Регистрация залога
    • 21 окт. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 06 мар. 1990 г.
    Поставлен 20 мар. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold property comprising the ground floor and mezzanine floor premises K.A. the canadian suite of the park tower hotel knightsbridge london SW1, and the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 мар. 1990 г.Регистрация залога
    • 21 окт. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 29 дек. 1988 г.
    Поставлен 11 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys now or at any time standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re zealcastle limited.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 11 янв. 1989 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 23 дек. 1988 г.
    Поставлен 09 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Flat 3 6 lawndes square london SW1, ground floor & mezzanine floor premises k/as canadian suite together with the lavatory accommodation serving the same at the park tower hotel knightsbridge london SW1 & other properties (please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken
    Транзакции
    • 09 янв. 1989 г.Регистрация залога
    Guarantee & debenture
    Создан 14 дек. 1988 г.
    Поставлен 23 дек. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 23 дек. 1988 г.Регистрация залога
    Guarantee & debenture
    Создан 28 июн. 1988 г.
    Поставлен 07 июл. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 07 июл. 1988 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 03 авг. 1987 г.
    Поставлен 12 авг. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 авг. 1987 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0