HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииHODGSON & HODGSON GROUP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01574452
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    • Производство других металлических изделий (25990) / Обрабатывающая промышленность
    • Прочие виды производства н.э.к. (32990) / Обрабатывающая промышленность
    • Покрытие полов и стен (43330) / Строительство
    • Консультирование по вопросам охраны окружающей среды (74901) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    OAKTIME LIMITED15 июл. 1981 г.15 июл. 1981 г.

    Каковы последние отчеты HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2015 г.

    Какие последние документы подавались HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    20 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 28 июн. 2020 г.

    23 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 28 июн. 2019 г.

    21 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 28 июн. 2018 г.

    24 страницыLIQ03

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Отчет о ходе администрации

    30 страницыAM10

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    31 страницыAM22

    Отчет о ходе администрации

    38 страницыAM10

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    1 страницыF2.18

    Заявление о предложениях администратора

    62 страницы2.17B

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    18 страницы2.16B

    Юридический адрес изменен с Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ на 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU 27 окт. 2016 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    Уведомление о подтверждении, составленное 07 сент. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Регистрация обременения 015744520013, создано 03 авг. 2016 г.

    18 страницыMR01

    Регистрация обременения 015744520016, создано 03 авг. 2016 г.

    15 страницыMR01

    Регистрация обременения 015744520014, создано 03 авг. 2016 г.

    17 страницыMR01

    Регистрация обременения 015744520015, создано 03 авг. 2016 г.

    15 страницыMR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    26 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital08 сент. 2015 г.

    Отчет о капитале на 08 сент. 2015 г.

    • Капитал: GBP 139,433.75
    SH01

    Изменение данных директора для Paul David Pickup 01 сент. 2015 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с Crown Industrial Estate Anglesey Road Burton-on-Trent Staffordshire DE14 3PA на Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ 01 сент. 2015 г.

    1 страницыAD01

    Регистрация обременения 015744520011, создано 08 июл. 2015 г.

    17 страницыMR01

    Регистрация обременения 015744520012, создано 08 июл. 2015 г.

    17 страницыMR01

    Кто является должностными лицами HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Секретарь
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    British11661720003
    GREEN, Kevin Jeffrey
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish83354170002
    LOFTUS, Gerard
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish199232130001
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish11661720003
    WEAVERS, Paul Barrington
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish63246890002
    WOOD, Martin Charles
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish102354760001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Секретарь
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    British25400000001
    PICKUP, Paul David
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    British11661720002
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001
    BALSHAW JONES, Glynne
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Директор
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish52751310002
    COMANDI, Juan Manuel
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Директор
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish117153380001
    DOYLE, Thomas John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Директор
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish159373190001
    GRUNDY, Nigel Arthur
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    Директор
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    United KingdomBritish6498450001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish25400000001
    HUGO, Gerald William
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    Директор
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842290001
    LONG, Brian Thomas
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    Директор
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842300002
    NARBURGH, Margaret
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    Директор
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    British83189380001
    PROFIT, John Anthony
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    Директор
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    British69219120001
    ROBERTS, John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Директор
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish32341560001
    ROLLINSON, Philip
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Директор
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish21921610001
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Wrogel Management Ltd
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    06 апр. 2016 г.
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act
    Место регистрацииEngland
    Регистрационный номер09353662
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 03 авг. 2016 г.
    Поставлен 04 авг. 2016 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Wrogel Management Limited
    Транзакции
    • 04 авг. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 03 авг. 2016 г.
    Поставлен 04 авг. 2016 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Wrogel Management Limited
    Транзакции
    • 04 авг. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 03 авг. 2016 г.
    Поставлен 04 авг. 2016 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Freeland land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Gerard Christopher Loftus
    Транзакции
    • 04 авг. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 03 авг. 2016 г.
    Поставлен 04 авг. 2016 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Freehold property known as 15 princewood road, corby NN17 4AP (described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby NN17 4AP) with title number NN130556.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Gerard Christopher Loftus
    Транзакции
    • 04 авг. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 08 июл. 2015 г.
    Поставлен 21 июл. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Gerard Christopher Loftus
    Транзакции
    • 21 июл. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 08 июл. 2015 г.
    Поставлен 21 июл. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Gerard Christopher Loftus
    Транзакции
    • 21 июл. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    Debenture
    Создан 28 июн. 2010 г.
    Поставлен 02 июл. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Close Invoice Finance LTD
    Транзакции
    • 02 июл. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 23 июн. 2000 г.
    Поставлен 04 июл. 2000 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 04 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 23 июн. 2000 г.
    Поставлен 04 июл. 2000 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property known as unit 14 sceptre road, crown business park, old dalby, melton mowbray, leicestershire LE14 3NQ t/no: LT308365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 04 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 23 июн. 2000 г.
    Поставлен 04 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property known as aldham house, 41A lady lane industrial estate, hadleigh t/no: SK119826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 04 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 23 июн. 2000 г.
    Поставлен 04 июл. 2000 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property known as 23 (formerly 15) princewood road, earlstree industrial estate, corby, northamptonshire t/no: NN130556. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 04 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 12 мар. 2000 г.
    Поставлен 21 мар. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor (as defined) to the chargee on any account whatsoever and incurred under any finance document (as defined)
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Транзакции
    • 21 мар. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июл. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 25 апр. 1997 г.
    Поставлен 09 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Транзакции
    • 09 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июл. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage debenture
    Создан 04 окт. 1985 г.
    Поставлен 14 окт. 1985 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charge over:- goodwill, bookdebts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 14 окт. 1985 г.Регистрация залога
    • 31 авг. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 янв. 1982 г.
    Поставлен 28 янв. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Estate Duties Investments Trust P.L.C.
    Транзакции
    • 28 янв. 1982 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 15 янв. 1982 г.
    Поставлен 28 янв. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Транзакции
    • 28 янв. 1982 г.Регистрация залога

    Есть ли у HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    18 окт. 2016 г.Начало управления
    29 июн. 2017 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2
    ДатаТип
    29 июн. 2017 г.Начало ликвидации
    18 авг. 2021 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0