TELEFLEX UK LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTELEFLEX UK LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01600496
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TELEFLEX UK LIMITED?

    • (7499) /

    Где находится TELEFLEX UK LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Teleflex Medical Uk
    Stirling Road
    HP12 3ST Cressex Business Park
    High Wycombe
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия TELEFLEX UK LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    IMO INDUSTRIES (UK) LIMITED22 дек. 1989 г.22 дек. 1989 г.
    BAIRD U.K. HOLDINGS LIMITED17 мар. 1982 г.17 мар. 1982 г.
    TOUCHVALE LIMITED27 нояб. 1981 г.27 нояб. 1981 г.

    Каковы последние отчеты TELEFLEX UK LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2008 г.

    Какие последние документы подавались TELEFLEX UK LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    legacy

    2 страницыSH20

    Отчет о капитале на 19 окт. 2009 г.

    • Капитал: GBP 1
    1 страницыSH19

    legacy

    2 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Cancel share prem a/c
    RES13

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность

    6 страницыAA

    Бухгалтерская отчетность

    6 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    legacy

    1 страницы190

    legacy

    1 страницы353

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы287

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    1 страницы288b

    Бухгалтерская отчетность

    6 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    2 страницы363a

    Кто является должностными лицами TELEFLEX UK LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Секретарь
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Irish127397580001
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Директор
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish127397580001
    WILLIAMS, Charles Edward
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    Директор
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    United StatesAmerican122869170001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Секретарь
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Секретарь
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Секретарь
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Секретарь
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    HARRISON, Brian
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    Секретарь
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    British13648350001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Секретарь
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Секретарь
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Секретарь
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    British71945940002
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Секретарь
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001
    STREETER, Andrew Charles
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    Секретарь
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    British69339090001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Директор
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Директор
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Директор
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Директор
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Директор
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BRADLEY, George Edward William
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    Директор
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    American76157540001
    BUSHELL, Anthony Thomas
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Директор
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    British69190050001
    CARROLL, Leffert
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Директор
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    American18905150001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Директор
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    DAWSON-GOODEY, Andrew John
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    Директор
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    British56963660001
    DERR LL, Robert
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    Директор
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    Usa47901970001
    GILL, John George
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    Директор
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    British58095740001
    GREEN, Raymond Charles
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    Директор
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    British27243660001
    HALL, Allan Robert Macalister
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    Директор
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    British68216820001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Директор
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    KING, Ian Robert
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    Директор
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish103274150002
    LAW, Michael Barry
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    Директор
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    British95044260001
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Директор
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    LEWIS, Brian
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    Директор
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    British18905160001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Директор
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    EnglandBritish71945940002
    MCCANN, Terence Michael Paul
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    Директор
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    British61786230001
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Директор
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001

    Есть ли у TELEFLEX UK LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Equitable share charge
    Создан 29 апр. 1996 г.
    Поставлен 03 мая 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement or any other loan document (as defined) and all of the obligations (as defined in the credit agreement) under the credit agreement and the other loan documents (as defined)
    Краткое описание
    (I) 2678,576 shares of £1 each in the capital of imo industries limited and (ii) 683,234 £1 shares each and 733,280 deferred £1 shares in the capital of morse controls limited; all other dividends/other income payable and all shares/other property from securities; all other rights,benefits,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Citicorp Usa,Inc.
    Транзакции
    • 03 мая 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 окт. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Equitable share charge
    Создан 16 нояб. 1994 г.
    Поставлен 28 нояб. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All money and liabilities now or hereafter due from the borrower (as defined) to the chargee under or pursuant to the credit agreement dated 5TH august 1994 (as defined) and any other loan document (as defined)
    Краткое описание
    All securities,dividends and other income payable; all shares or other property; all other rights,benefits......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Citibank,N.a,as Agent for Itself,the Lenders and the Issuing Banks
    Транзакции
    • 28 нояб. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 02 сент. 1993 г.
    Поставлен 09 сент. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 сент. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 июн. 1994 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 26 мая 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0