ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01817913
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    • Прочие виды деятельности в области информационных технологий (62090) / Информация и связь

    Где находится ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Юридический адрес
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED12 июн. 2002 г.12 июн. 2002 г.
    AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED21 мая 1984 г.21 мая 1984 г.

    Каковы последние отчеты ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2012 г.

    Каков статус последней годовой декларации для ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Предыдущий отчетный период продлен

    3 страницыAA01

    Прекращение полномочий Andrew Thomson в качестве директора

    2 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital27 авг. 2013 г.

    Отчет о капитале на 27 авг. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1
    SH01

    Отчет о капитале на 24 июн. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыSH20

    Решения

    Resolutions
    4 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Назначение David William Hart Gray на должность секретаря

    3 страницыAP03

    Прекращение полномочий Gareth Wilson в качестве секретаря

    2 страницыTM02

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Решения

    Resolutions
    34 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Регистры перемещены по юридическому адресу

    1 страницыAD04

    Прекращение полномочий Adrian Stevens в качестве директора

    2 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Изменение данных директора для Mr Adrian Charles Stevens 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Andrew James Edward Thomson 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Mr Gareth Antony Wilson 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH03

    Изменение данных директора для Mr Andrea Fiumicelli 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* 18 авг. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Юридический адрес изменен с * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* 05 авг. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Кто является должностными лицами ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357740001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishComputer Consultant17678130002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Секретарь
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Секретарь
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Секретарь
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Секретарь
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    British5361780001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045740001
    CLARKE, Robert Samuel
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishSales & Marketing44712370001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Директор
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWLES, Neil
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    Директор
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    BritishDirector79753520001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director17678130002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    Директор
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    EALES, Gillian Margaret
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    Директор
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    BritishBusiness Administrator16296060001
    FRANKS, Nigel
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    Директор
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director39004110002
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Директор
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Директор
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Директор
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Директор
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Директор
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant178097680001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Директор
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    BritishDoctor5361780001
    MORRIS, Eamonn
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    Директор
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector65876940001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Директор
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RAWCLIFFE, Richard William
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    Директор
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    BritishDirector86831530001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Директор
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    RICHARDS, Paul
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector82595090001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WATSON, Robert John
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director16296070002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Директор
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Директор
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Директор
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002

    Есть ли у ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Security agreement
    Создан 30 дек. 2009 г.
    Поставлен 13 янв. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 13 янв. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A deed of accession
    Создан 27 нояб. 2007 г.
    Поставлен 13 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Транзакции
    • 13 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Создан 24 авг. 2006 г.
    Поставлен 31 авг. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee and Agent for the Lenders as Defined in the Facility Agreement)(the Security Trustee)
    Транзакции
    • 31 авг. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 апр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 24 авг. 2006 г.
    Поставлен 31 авг. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 31 авг. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Создан 13 апр. 2006 г.
    Поставлен 28 апр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 28 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Создан 08 авг. 2002 г.
    Поставлен 16 авг. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 16 авг. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 авг. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 04 апр. 2001 г.
    Поставлен 07 апр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 07 апр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 апр. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0