GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED

GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01903989
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    • Прочая социальная работа без обеспечения н.в.и.д. (88990) / Здравоохранение и социальные услуги

    Где находится GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Юридический адрес
    Cavendish House Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    INDEPENDENT HOME CARE & NURSING SERVICES LIMITED03 июн. 1985 г.03 июн. 1985 г.
    RINDLEFORD LIMITED11 апр. 1985 г.11 апр. 1985 г.

    Каковы последние отчеты GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2016 г.

    Какие последние документы подавались GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Уведомление о подтверждении, составленное 12 янв. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Carl Michael Brown в качестве директора 21 дек. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Уведомление о подтверждении, составленное 12 янв. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий John Henry Whitehead в качестве директора 12 июн. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Carl Michael Brown на должность директора 12 июн. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 12 янв. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Решения

    Resolutions
    20 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Прекращение полномочий Richard Mark Preece в качестве директора 16 февр. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital15 янв. 2016 г.

    Отчет о капитале на 15 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 2,000,000
    SH01

    Назначение Mr Richard Mark Preece на должность директора 11 янв. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Timothy Mark Pethick в качестве директора 31 дек. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Timothy Mark Pethick в качестве директора 31 дек. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Victoria Haynes в качестве секретаря 01 дек. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE на Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX 03 дек. 2015 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Назначение Mr Timothy Mark Pethick на должность директора 09 сент. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Darryn Stanley Gibson в качестве директора 09 сент. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr John Henry Whitehead 01 мар. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital12 янв. 2015 г.

    Отчет о капитале на 12 янв. 2015 г.

    • Капитал: GBP 2,000,000
    SH01

    Кто является должностными лицами GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Секретарь
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    DAVIES, John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Секретарь
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    158562770001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Секретарь
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171613310001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Секретарь
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    BritishCompany Secretary76032450005
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Секретарь
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Директор
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector147928010001
    BROWN, Carl Michael
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    Директор
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    EnglandBritishAccountant232841280001
    CHRISTODOULOU, Nicholas John
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    Директор
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    BritishChartered Accountant62742480002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Директор
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector Corporate Finance29367700001
    DIXON, Catherine Helen
    7 Ashwood Terrace
    LS6 2EH Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    7 Ashwood Terrace
    LS6 2EH Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor100792180001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector40582650004
    ELLIS, Martyn Anthony
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    Директор
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director95749550002
    FARRAND, Clive
    20 Ladybower Avenue
    Cowlersley
    HD4 5XA Huddersfield
    West Yorkshire
    Директор
    20 Ladybower Avenue
    Cowlersley
    HD4 5XA Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishManaging Director34882440001
    FIRTH, Alan Stuart
    21 Inglewood Avenue
    Birkby
    HD2 2DS Huddersfield
    West Yorkshire
    Директор
    21 Inglewood Avenue
    Birkby
    HD2 2DS Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector4282370001
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Директор
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector21934910001
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Директор
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    GREENE, Kevin Anthony
    Bethena 25 Alexandra Road
    Ash
    GU12 6PQ Aldershot
    Hampshire
    Директор
    Bethena 25 Alexandra Road
    Ash
    GU12 6PQ Aldershot
    Hampshire
    BritishCompany Director48212370002
    GRUBIC, Paul
    13 Bailey Hills Road
    BD16 2RJ Bingley
    West Yorkshire
    Директор
    13 Bailey Hills Road
    BD16 2RJ Bingley
    West Yorkshire
    BritishDeputy Managing Director42880160001
    HAYES, Dominic Patrick Thomas
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    Директор
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    EnglandBritishProperty Director126532450001
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Директор
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director160271430001
    IVERS, John Joseph
    Sandon Brook Manor
    Maldon Road
    CM2 7RZ Chelmsford
    Brook Lodge
    Essex
    Директор
    Sandon Brook Manor
    Maldon Road
    CM2 7RZ Chelmsford
    Brook Lodge
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director77692980002
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Директор
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director39701670001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Директор
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrishUk Finance Director26911740008
    LOUGHLIN, Timothy Patrick
    54 Wrenbeck Drive
    LS21 2BR Otley
    West Yorkshire
    Директор
    54 Wrenbeck Drive
    LS21 2BR Otley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director46683550001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director51084280003
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director64514410001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Директор
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director172197670001
    PREECE, Richard Mark
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Директор
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director97531900001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector142125320001
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Директор
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director57380020001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Директор
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritishChartered Accountant62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Директор
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor6658190001
    WHEATON, James Gordon
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Директор
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant77841040001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Nestor Primecare Services Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 апр. 2016 г.
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииCompanies House England And Wales
    Регистрационный номер1963820
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у GOLDSBOROUGH HOMECARE & NURSING SERVICES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A security agreement
    Создан 16 нояб. 2009 г.
    Поставлен 23 нояб. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Party
    Транзакции
    • 23 нояб. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 21 июл. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Rent deposit deed
    Создан 15 июл. 1999 г.
    Поставлен 17 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The sum of £4,134 paid and credited to the bank deposit account pursuant to the rent deposit deed dated 12/05/99 and all interest and other monies paid or credited to the bank deposit account.
    Уполномоченные лица
    • First Quantum Property Investments Limited
    Транзакции
    • 17 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 12 окт. 1992 г.
    Поставлен 21 окт. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture"
    Краткое описание
    See doc ref M566C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank Plcand Each of the Banksin Its Capacity as Agent and Trustee for Itself
    Транзакции
    • 21 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 апр. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Создан 06 мар. 1991 г.
    Поставлен 20 мар. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents (as defined).
    Краткое описание
    Various properties as defined in form 395 ref. M79.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank Plcernor & Company of the Bank of Scotland)(For Itself National Westminster PLC and the Gov
    Транзакции
    • 20 мар. 1991 г.Регистрация залога
    • 27 апр. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 17 дек. 1990 г.
    Поставлен 21 дек. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    First first charge on all book and other debts floating charge on all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1990 г.Регистрация залога
    • 24 июл. 1992 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 06 сент. 1989 г.
    Поставлен 12 сент. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from goldsborough limited and/or goldsborough developments limited and/or goldsborough homecare services (pendle) limited and/or piper higginson limited to the chargee on any account whatsoever.
    Краткое описание
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Уполномоченные лица
    • Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Транзакции
    • 12 сент. 1989 г.Регистрация залога
    Letter of charge
    Создан 20 июн. 1988 г.
    Поставлен 05 июл. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever.
    Краткое описание
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Уполномоченные лица
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 05 июл. 1988 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 24 июл. 1986 г.
    Поставлен 13 авг. 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 13 авг. 1986 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 12 дек. 1985 г.
    Поставлен 23 дек. 1985 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £9,000
    Краткое описание
    First floating charge on all (see M12). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Suratip Porter
    Транзакции
    • 23 дек. 1985 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0