YWC GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииYWC GROUP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01939258
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель YWC GROUP LIMITED?

    • Производство прочих пластиковых изделий (22290) / Обрабатывающая промышленность
    • Прочие строительно-монтажные работы (43290) / Строительство

    Где находится YWC GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия YWC GROUP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    YORKSHIRE WINDOW CO. LTD.21 мая 1986 г.21 мая 1986 г.
    FINCHALTON LIMITED15 авг. 1985 г.15 авг. 1985 г.

    Каковы последние отчеты YWC GROUP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2015 г.

    Какие последние документы подавались YWC GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    24 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 18 янв. 2020 г.

    24 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 18 янв. 2019 г.

    24 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 18 янв. 2018 г.

    26 страницыLIQ03

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    2 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    2 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    2 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    2 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    2 страницыF10.2

    Юридический адрес изменен с Hellaby Industrial Estate Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN на 4th Floor Fountain Precinct Leopold Street Sheffield S1 2JA 10 февр. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Отчет о состоянии дел с приложенной формой 4.19

    16 страницы4.20

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации с даты начала дела 19 янв. 2017 г.

    LRESEX

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 авг. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Прекращение полномочий Kevin Taylor в качестве директора 10 июн. 2016 г.

    2 страницыTM01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    26 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    8 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital02 сент. 2015 г.

    Отчет о капитале на 02 сент. 2015 г.

    • Капитал: GBP 60,800
    SH01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    27 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    8 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital07 окт. 2014 г.

    Отчет о капитале на 07 окт. 2014 г.

    • Капитал: GBP 60,800
    SH01

    Прекращение полномочий Steven Roger Cousins в качестве директора 30 июн. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Steven Roger Cousins на должность секретаря

    1 страницыAP03

    Назначение Steven Roger Cousins на должность директора 25 июл. 2006 г.

    1 страницыAP01

    Прекращение полномочий Jonathan Bailey в качестве директора

    2 страницыTM01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA

    Кто является должностными лицами YWC GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Секретарь
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    British114656960001
    CARTER, Rex Andrew
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    Директор
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    United KingdomBritish82322290002
    CHESTER, Ian Robert
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    Директор
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish181466460001
    COUSINS, Steven Roger
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    Директор
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    United KingdomBritish181551540001
    YARLETT, Michael Stewart
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    Директор
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    EnglandBritish33028840004
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Номинированный секретарь
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    ADDY, Christopher
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandEnglish93315810001
    ALLSOPP, Richard Malcolm
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    British3241690001
    BAILEY, Jonathan Trevor
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    Директор
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish169581220001
    BLAGDEN, John Charles
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    Директор
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    British19379850002
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Директор
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish114656960001
    KEENAN, Robert
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish70765950001
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Номинированный директор
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    RIGBY, Edwin John
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    Директор
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    United KingdomBritish87672510001
    SCOTT, Paul Graham
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    British19379840001
    SHAW, Anthony
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    Директор
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    British19379820003
    TAYLOR, Kevin
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish81151010003
    WILSON, Howard James
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    Директор
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    British46326000001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над YWC GROUP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Mr Michael Stewart Yarlett
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    25 авг. 2016 г.
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    Нет
    Гражданство: British
    Страна проживания: England
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у YWC GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 01 мая 2013 г.
    Поставлен 07 мая 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    A. by way of first legal mortgage the specified real property namely;. 1. unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate, hellaby, rotherham, south yorkshire as the same is contained in SYK253742. 2. land on the south west side of braithwell way, hellaby industrial estate yorkshire as the same is contained in SYK365435. 3. land on the south west side of bramley way, hellaby industrial estate, hellaby yorkshire as the same is contained in SYK365434. B. by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 4.1(a));. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. C. by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 3 of schedule 1;. D. by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 4.1(n);. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Centric SPV1 Limited
    Транзакции
    • 07 мая 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    Legal charge
    Создан 20 апр. 2012 г.
    Поставлен 27 апр. 2012 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and premises at bramley way hellaby rotherham t/no SYK253742 SYK365435 SYK365434.
    Уполномоченные лица
    • Michael Stewart Yarlett
    Транзакции
    • 27 апр. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    Deposit agreement
    Создан 24 апр. 2006 г.
    Поставлен 27 апр. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    £3,231.25 and the monies held in the account.
    Уполномоченные лица
    • Yorkshire Window Company Limited
    Транзакции
    • 27 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 10 дек. 2003 г.
    Поставлен 12 дек. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 12 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Legal mortgage
    Создан 10 дек. 2003 г.
    Поставлен 12 дек. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate hellaby t/n SYK253742. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 12 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 25 июн. 1997 г.
    Поставлен 05 июл. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H land and buildings k/a unit bt 512/3 a-f hellaby industrial estate hellaby rotherham south yorkshire t/no;-SYK253742 together with goodwill of any business at the property and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 05 июл. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 22 февр. 1988 г.
    Поставлен 24 февр. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All that f/h property situate and k/a factory unit no: bt 51213 on the hellaby industrial estate rotherham south yorkshire.
    Уполномоченные лица
    • The English Industrial Estates Corporation
    Транзакции
    • 24 февр. 1988 г.Регистрация залога
    • 01 апр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 30 апр. 1986 г.
    Поставлен 08 мая 1986 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 08 мая 1986 г.Регистрация залога
    • 25 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у YWC GROUP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    19 янв. 2017 г.Начало ликвидации
    24 июн. 2021 г.Дата планируемой ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Adrian Graham
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    Практик
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0