HEG (NUMBER 1) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииHEG (NUMBER 1) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 01984677
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    • (5146) /

    Где находится HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Юридический адрес
    822 Fountain Court
    Birchwood Boulevard Birchwood
    WA3 7QZ Warrington
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    FIRST AID UK LTD10 мар. 1993 г.10 мар. 1993 г.
    STAFFORDSHIRE FIRST AID SUPPLIES LIMITED02 апр. 1986 г.02 апр. 1986 г.
    DATECOVER LIMITED31 янв. 1986 г.31 янв. 1986 г.

    Каковы последние отчеты HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2009 г.

    Какие последние документы подавались HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Юридический адрес изменен с 17 Chesford Grange Woolston Warrington Cheshire WA1 4RQ 27 мая 2010 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital26 мая 2010 г.

    Отчет о капитале на 26 мая 2010 г.

    • Капитал: GBP 500
    SH01

    Изменение данных директора для Lyndon James Gaborit 26 мая 2010 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    Бухгалтерская отчетность

    4 страницыAA

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    4 страницы363a

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed first aid uk LTD\certificate issued on 25/04/08
    3 страницыCERTNM

    legacy

    1 страницы225

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    legacy

    2 страницы363a

    legacy

    1 страницы287

    legacy

    1 страницы288b

    Бухгалтерская отчетность

    9 страницыAA

    legacy

    3 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    3 страницы288a

    legacy

    1 страницы403a

    legacy

    7 страницы363s

    legacy

    1 страницы288b

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    Кто является должностными лицами HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Секретарь
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Директор
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    Директор
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    United KingdomAustralian133660360001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Секретарь
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    British54189670005
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    Секретарь
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    American93963450001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Секретарь
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Секретарь
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    British114397290001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Директор
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish54189670005
    BRUCK, Stuart
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    Директор
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    American57236400002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Директор
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Директор
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish114397290001
    PEAR, Graham
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    Директор
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish13275040003
    PEAR, Graham
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    Директор
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    British13275040001
    PEAR, Susan Dawn
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    Директор
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    British100025290001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Директор
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritish109723760001
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    Директор
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    British136141810001

    Есть ли у HEG (NUMBER 1) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of accession and charge
    Создан 28 июн. 2004 г.
    Поставлен 01 июл. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 01 июл. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 06 сент. 2002 г.
    Поставлен 21 сент. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings on the north east side of back lane radnor park industrial estate congleton cheshire CW12 t/n CH442637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 сент. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 29 окт. 2001 г.
    Поставлен 02 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the financing agreement (as defined in the fixed and floating charge)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Транзакции
    • 02 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 23 июн. 1999 г.
    Поставлен 06 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a 14 silk street congleton cheshire t/no: CH360920. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 06 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мая 1997 г.
    Поставлен 24 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    First fixed charge all book and other debts of the company põresent and future save for book and other debts sold by the company and purchased by the security holder under an invoice discounting agreement and not repurchased pursuant to the provisions thereof.
    Уполномоченные лица
    • New Court Commercial Finance Limited
    Транзакции
    • 24 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 30 янв. 1997 г.
    Поставлен 19 февр. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/Hold property known as 12 silk st,congleton cheshire and the proceeds of sale thereof; t/no ch 331506. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 19 февр. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 22 янв. 1991 г.
    Поставлен 28 янв. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    See form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 28 янв. 1991 г.Регистрация залога
    • 11 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0