AESSEAL PLC

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииAESSEAL PLC
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаПубличная акционерная компания
    Номер компании 02101607
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель AESSEAL PLC?

    • Прочие виды производства н.э.к. (32990) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится AESSEAL PLC?

    Юридический адрес
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия AESSEAL PLC?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    AESSEAL SE PLC06 апр. 1999 г.06 апр. 1999 г.
    SEALTEC S E PLC09 янв. 1991 г.09 янв. 1991 г.
    G.V.S. ENGINEERING LIMITED05 авг. 1987 г.05 авг. 1987 г.
    PERFLED LIMITED19 февр. 1987 г.19 февр. 1987 г.

    Каковы последние отчеты AESSEAL PLC?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июн. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для AESSEAL PLC?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на25 июл. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено08 авг. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на25 июл. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались AESSEAL PLC?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Назначение Mr John Harry Wilks на должность директора 20 дек. 2024 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr John Harry Wilks на должность секретаря 20 дек. 2024 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Claire Louise Dickinson в качестве директора 20 дек. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Nazim Raza Shabir в качестве директора 24 сент. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Nazim Raza Shabir в качестве секретаря 24 сент. 2024 г.

    1 страницыTM02

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 июл. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    42 страницыAA

    Полное погашение обременения 5

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 021016070007

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    2 страницыMR04

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 июл. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    42 страницыAA

    Назначение Mr Joshua William Banks на должность директора 23 мар. 2023 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Rosalie Rea в качестве директора 25 янв. 2023 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Mark Owen Williams в качестве директора 31 дек. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 июл. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    42 страницыAA

    Вторая подача заявления о назначении Mr John Henry Chappell директором

    3 страницыRP04AP01

    Скорректированная годовая бухгалтерская отчетность

    40 страницыAAMD

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 июл. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    33 страницыAA

    Прекращение полномочий Andrew Colverson в качестве директора 06 янв. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Nazim Raza Shabir на должность секретаря 01 янв. 2021 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Stephen Martin Dodd в качестве секретаря 31 дек. 2020 г.

    1 страницыTM02

    Назначение Mr John Henry Chappell на должность директора 26 окт. 2020 г.

    3 страницыAP01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    08 сент. 2021 г.Clarification A second filed AP01 was registered on 08/09/21

    Кто является должностными лицами AESSEAL PLC?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    WILKS, John Harry
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Секретарь
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    330581030001
    BANKS, Joshua William
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector262656830001
    CHAPPELL, John Henry
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    WalesBritishManaging Director275835410001
    REA, Christopher John
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandNorthern IrishCompany Director6929300002
    WELSH, James Stuart
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector201138150001
    WILKS, John Harry
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director330653250001
    BRIDGE, Gordon Wilson
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    Секретарь
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    BritishCompany Director5201640001
    CALDWELL, John Christopher
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Секретарь
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    175791010001
    DICKINSON, Claire Louise
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Секретарь
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    178733340001
    DODD, Stephen Martin
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Секретарь
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    201138630001
    HODSON, Neville John
    High Reach
    High Bradfield
    S6 6LG Sheffield
    Секретарь
    High Reach
    High Bradfield
    S6 6LG Sheffield
    British45516800002
    SHABIR, Nazim Raza
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Секретарь
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    278134550001
    WILLIAMS, Leigh Ann
    23 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    Секретарь
    23 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    British6929310001
    BINGHAM, Glyn Barry
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector78775080002
    BLAGDEN, Simon Paul
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector128545130006
    BRIDGE, Gordon Wilson
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector5201640001
    BRIDGE, Gordon Wilson
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector5201640001
    BRIDGE, Gordon Wilson
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    Директор
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    EnglandBritishCompany Director5201640001
    COLLINS, Steven John
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer168691940001
    COLVERSON, Andrew
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector201137870001
    CONGER, Hamdi
    7 Briar Road
    NG16 2BN Newthorpe
    Nottinghamshire
    Директор
    7 Briar Road
    NG16 2BN Newthorpe
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector107322570001
    COOK, Richard Stephenson
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director80001420001
    DICKINSON, Claire Louise
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishFinancial Controller201137570001
    GUPPY, Colin Desmond
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector106774760001
    HARRISON, Michael Robert
    22 The Grange Road
    LS16 6HA Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    22 The Grange Road
    LS16 6HA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishI P Director27239820001
    MACDONALD, Neil Andrew
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    Директор
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector3696630003
    MCKERVEY, Martin James Claude
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandIrishCompany Director142400130001
    OWEN, David Colin
    4 Cuttle Hill Gardens
    East Bridgford
    NG13 8PW Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    4 Cuttle Hill Gardens
    East Bridgford
    NG13 8PW Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director80001450002
    PICKLES, Thomas Richard
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector134826920001
    REA, Rosalie
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director17408470002
    RODDIS, Alan James
    27 Newton Vale
    Chapeltown
    S35 2YL Sheffield
    South Yorkshire
    Директор
    27 Newton Vale
    Chapeltown
    S35 2YL Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director75236990002
    SELKA, James David
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector36401830001
    SHABIR, Nazim Raza
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector180157220001
    SHAW, Stephen Martin
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDir78291310001
    SMITH, Richard Jonathan
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    Директор
    Global Technology Centre
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Mill Close Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector201172980001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над AESSEAL PLC?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Mill Close
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Rotherham
    Global Technology Centre
    South Yorkshire
    England
    06 апр. 2016 г.
    Mill Close
    Bradmarsh Business Park
    S60 1BZ Rotherham
    Global Technology Centre
    South Yorkshire
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUk
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер00392743
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у AESSEAL PLC какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 01 февр. 2016 г.
    Поставлен 04 февр. 2016 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 04 февр. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 29 мая 2024 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 23 дек. 2009 г.
    Поставлен 08 янв. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Test house to the west of bradmarsh way templeborough rotherham t/no's SYK368908 (part) and SYK402685 (part) with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 08 янв. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 29 мая 2024 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 18 сент. 2000 г.
    Поставлен 19 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from A.E.S. engineering limited and by the mortgagor on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land being part of unit 11 saxon house upminster trading park brentwood essex EX606686. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 19 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мая 2024 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Mortgage
    Создан 10 мар. 1999 г.
    Поставлен 19 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Краткое описание
    F/H land and buildings k/a part of unit 11 saxon house upminster trading park essex t/no: EX606686 together with all buildings and fixtures (including trade and other fixtures) and fixed plant and machinery of the company from time to time thereon and the proceeds of sale.
    Уполномоченные лица
    • 3I Group PLC
    Транзакции
    • 19 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 окт. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 04 мар. 1999 г.
    Поставлен 09 мар. 1999 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    But excluding freehold or leasehold or other immoveable property of the company. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 09 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    Legal charge
    Создан 28 мар. 1991 г.
    Поставлен 12 апр. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Unit 11, saxon house, upminster trading park, warley street, warley, essex.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 апр. 1991 г.Регистрация залога
    • 13 мар. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 10 июн. 1988 г.
    Поставлен 16 июн. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 июн. 1988 г.Регистрация залога
    • 13 мар. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0