LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииLE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02116902
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    • Производство хлеба; производство свежих изделий из теста и тортов (10710) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Юридический адрес
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    PINGATE CATERING LIMITED30 мар. 1987 г.30 мар. 1987 г.

    Каковы последние отчеты LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2011 г.

    Какие последние документы подавались LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital26 сент. 2012 г.

    Отчет о капитале на 26 сент. 2012 г.

    • Капитал: GBP 1,248
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Назначение Emmett Mcevoy на должность директора 20 апр. 2012 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Antony David Smith в качестве директора 20 апр. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Andrew Mcdonald на должность директора 15 нояб. 2011 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Suzanne Elizabeth Wise в качестве директора 15 нояб. 2011 г.

    1 страницыTM01

    Решения

    Resolutions
    34 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01
    capital

    Решение о размещении ценных бумаг

    RES10

    Заявление о предмете деятельности общества

    2 страницыCC04

    Уведомление об отмене ограничений в уставе общества

    2 страницыCC02

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Изменение данных директора для Ms Suzanne Elizabeth Wise 01 июл. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Mr Simon Nicholas Wilbraham 01 июл. 2011 г.

    1 страницыCH03

    Изменение данных директора для Mr Andrew Michael Peeler 01 июл. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Назначение Mr Antony David Smith на должность директора

    3 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Peeler в качестве директора

    2 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Назначение Mr Simon Nicholas Wilbraham на должность директора

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    11 страницыAR01

    Прекращение полномочий Robert Lawson в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Секретарь
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Директор
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Директор
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Секретарь
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Секретарь
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Секретарь
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Секретарь
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    British66183100001
    VANBERGEN, Charles Albert
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    Секретарь
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    British7384900001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Секретарь
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Директор
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BARRY, Peter Nigel George
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    Директор
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    EnglandBritish84886660001
    CARTER, Ian Paul
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    Директор
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish79314210001
    CHARTERIS, Derek William
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136986090001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Директор
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Директор
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DARA, Alireza
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    Директор
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    United KingdomBritish22461240001
    DAVIES, Lyn Theodore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    Директор
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    British34304310003
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Директор
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FORREST, Keith Robert Mckenzie
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    Директор
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    British45838740001
    HARRIS, Gareth Addison
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish152131210001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Директор
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    HOLROYD, Dean
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    Директор
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    British64875220002
    HYDE, Trevor John
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    Директор
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    British71827110001
    JONES, Martin William
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    Директор
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    British26034610001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Директор
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MALPUS, John James
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    Директор
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    British6799180003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Директор
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Директор
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Директор
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Директор
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    RELF, Russell Alan
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    Директор
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    British59133030001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Директор
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001

    Есть ли у LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined)
    Создан 28 февр. 2001 г.
    Поставлен 20 мар. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis.
    Краткое описание
    All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Chase Manhattan Bank (As Borrower Security Trustee)
    Транзакции
    • 20 мар. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 сент. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Создан 11 сент. 2000 г.
    Поставлен 23 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Транзакции
    • 23 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 18 нояб. 1997 г.
    Поставлен 21 нояб. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 21 нояб. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 июл. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 14 нояб. 1997 г.
    Поставлен 18 нояб. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 18 нояб. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 июл. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 19 мар. 1997 г.
    Поставлен 20 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £708,265 due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 20 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 07 мар. 1997 г.
    Поставлен 08 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 08 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 10 дек. 1996 г.
    Поставлен 13 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Транзакции
    • 13 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 15 июл. 1996 г.
    Поставлен 20 июл. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 20 июл. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattels mortgage
    Создан 11 июл. 1996 г.
    Поставлен 11 июл. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Forward Trust Limited
    Транзакции
    • 11 июл. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 09 мая 1996 г.
    Поставлен 11 мая 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Краткое описание
    Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 11 мая 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 02 окт. 1995 г.
    Поставлен 04 окт. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Краткое описание
    1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 04 окт. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 01 авг. 1995 г.
    Поставлен 02 авг. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 02 авг. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Credit agreement
    Создан 26 авг. 1993 г.
    Поставлен 07 сент. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Краткое описание
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Close Brothers Limited
    Транзакции
    • 07 сент. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 июл. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Collateral debenture
    Создан 27 нояб. 1991 г.
    Поставлен 29 нояб. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • 3I Group PLC
    Транзакции
    • 29 нояб. 1991 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 сент. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 15 окт. 1988 г.
    Поставлен 04 нояб. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 04 нояб. 1988 г.Регистрация залога
    • 11 авг. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0