DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииDAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02250014
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    • (7499) /

    Где находится DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    Юридический адрес
    Beech House Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Berkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    PUREPLAS LIMITED06 июн. 1988 г.06 июн. 1988 г.
    MECHCERTAIN LIMITED29 апр. 1988 г.29 апр. 1988 г.

    Каковы последние отчеты DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2011 г.

    Какие последние документы подавались DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Отчет о капитале на 05 апр. 2012 г.

    • Капитал: GBP 10
    4 страницыSH19

    Заявление о предмете деятельности общества

    2 страницыCC04

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Share premium cancelled 30/03/2012
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Назначение Matthew Paul Jowett на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Carolyn Cattermole в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Прекращение полномочий Anthony Thorne в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Miles William Roberts на должность директора

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Изменение данных директора для Anthony David Thorne 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Carolyn Tracy Cattermole 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Stephen William Dryden 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Anne Steele 01 окт. 2009 г.

    1 страницыCH03

    legacy

    4 страницы363a

    legacy

    1 страницы287

    Бухгалтерская отчетность

    5 страницыAA

    Кто является должностными лицами DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    STEELE, Anne
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Секретарь
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British77624110001
    DRYDEN, Stephen William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Директор
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    EnglandBritish47821400004
    JOWETT, Matthew Paul
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Директор
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    EnglandBritish205867540001
    ROBERTS, Miles William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Директор
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    EnglandBritish57880630003
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Секретарь
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    British53026290001
    RICHARDSON, Alan John
    118 Paxford Road
    Sudbury Court
    HA0 3RH North Wembley
    Middlesex
    Секретарь
    118 Paxford Road
    Sudbury Court
    HA0 3RH North Wembley
    Middlesex
    British43179370001
    RUSSELL, John Stuart
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Секретарь
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British480230002
    STEPHENSON, Mildred Ann
    48 Eastern Way
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9PF Newcastle Upon Tyne
    Секретарь
    48 Eastern Way
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9PF Newcastle Upon Tyne
    British81308700001
    THOMPSON, Andrew William Brown
    68 St Georges Terrace
    Jesmond
    NE2 2DL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Секретарь
    68 St Georges Terrace
    Jesmond
    NE2 2DL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British42215530001
    BUTTFIELD, David Frank
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    British37624090002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Директор
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United KingdomBritish53026290002
    CROMBIE, John Stone
    73 Durham Road
    DL14 7HX Bishop Auckland
    County Durham
    Директор
    73 Durham Road
    DL14 7HX Bishop Auckland
    County Durham
    British19206800001
    GREEN, Michael George
    Thorniethwaite
    DG11 1JH Lockerbie
    Dumfries
    Директор
    Thorniethwaite
    DG11 1JH Lockerbie
    Dumfries
    ScotlandBritish23613980001
    MILLER, John Michael
    12 Stanley Gardens
    W11 2NE London
    Директор
    12 Stanley Gardens
    W11 2NE London
    British52277980001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Директор
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritish16228990001
    RUSSELL, John Stuart
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Директор
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British480230002
    STEPHENSON, Keith
    48 Eastern Way, Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PF Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Директор
    48 Eastern Way, Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PF Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British38596040001
    THORNE, Anthony David
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Директор
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United KingdomBritish40130640001
    WILLIAMS, John Peter
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    Директор
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    United KingdomBritish707720002

    Есть ли у DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Fixed charge
    Создан 23 мар. 1993 г.
    Поставлен 25 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £205,000 due from the company to the chagree under the terms of the fixed charge
    Краткое описание
    Uniloy 250 ri blow molding machine serial number 4391 (cable conveyor system - blow moulder to bagger including single tier bagger).
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 25 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 нояб. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A credit agreement
    Создан 27 окт. 1992 г.
    Поставлен 30 окт. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £23,956.50 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement.
    Краткое описание
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance see relevant form 395 and schedule for full details.
    Уполномоченные лица
    • Close Brothers Limited
    Транзакции
    • 30 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 апр. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 окт. 1992 г.
    Поставлен 22 окт. 1992 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed od guarantee of evendate
    Краткое описание
    First all that piece of land being sites nos. BT101/15A-g on english industrial estates corporation's number one industrial estate consett,co durham secondly the factories and other erections and buildings thereon erected and built and the landlords' fixtures and fittings therein.
    Уполномоченные лица
    • English Industrial Estates Corporation
    Транзакции
    • 22 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    Mortgage deed
    Создан 14 окт. 1992 г.
    Поставлен 22 окт. 1992 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Charge by way of legal mortgage over thel/h property k/a units BT101/15A-g inclusive,number 1 industrial estate,medomsley road,consett including the entirety of the property comprised in the lease datet 14 october 1992 between english industrial estates corporation and pureplus limited together with all buildings and fixtures thereon. Assigns the goodwill of the business carried on by the mortgagor at the mortgaged premises see relevant form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 22 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    Fixed charge
    Создан 06 июл. 1992 г.
    Поставлен 09 июл. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £120,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    A first charge over: one uniloy 2016 blow-moulding machine for the production of 4 pint handle type 40 gram net weight dairy bottles from 3 mould cavities. See form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 09 июл. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 нояб. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 19 апр. 1991 г.
    Поставлен 24 апр. 1991 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 19 april 1991
    Краткое описание
    See form 395 for details of plant and machinery together with the benefit of any odligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the plant and machinery to or in favour of the company and the benefit of all maintenance agreements.
    Уполномоченные лица
    • Greyhound Bank PLC
    Транзакции
    • 24 апр. 1991 г.Регистрация залога
    Chattel mortgage
    Создан 26 февр. 1991 г.
    Поставлен 01 мар. 1991 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 26/2/91 on any account
    Краткое описание
    One used onley model 2011 blow moulding machine serial no 2533 with moulds together with the benefit of any odligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the machine to or in favour of the company.
    Уполномоченные лица
    • Greyhound Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 1991 г.Регистрация залога
    Chattel mortgage
    Создан 20 янв. 1989 г.
    Поставлен 24 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Sterling pounds 50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Краткое описание
    Automa blow moulding machines number 8DE902088 31404.
    Уполномоченные лица
    • British Coal Enterprise Limited
    Транзакции
    • 24 янв. 1989 г.Регистрация залога
    • 11 мая 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Single debenture
    Создан 06 дек. 1988 г.
    Поставлен 15 дек. 1988 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 15 дек. 1988 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 07 окт. 1988 г.
    Поставлен 13 окт. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H units BT101/15F and BT101/15G, NO1 industrial estate, consett, county durhamstock in trade, work in progress prepayments, investments and cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • 3I PLC
    Транзакции
    • 13 окт. 1988 г.Регистрация залога
    • 19 дек. 1991 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0