FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииFRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02250022
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    • Покупка и продажа собственной недвижимости (68100) / Операции с недвижимым имуществом
    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Юридический адрес
    50 Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    RACESHIELD LIMITED29 апр. 1988 г.29 апр. 1988 г.

    Каковы последние отчеты FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на13 июл. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено27 июл. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на13 июл. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Уведомление о подтверждении, составленное 13 июл. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    13 страницыAA

    Регистрация обременения 022500220024, создано 20 дек. 2023 г.

    35 страницыMR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    23 страницыAA

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 022500220023

    2 страницыMR05

    Уведомление о подтверждении, составленное 13 июл. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Изменение данных секретаря для Newcore Capital Management Llp 01 янв. 2023 г.

    2 страницыCH04

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    17 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 13 июл. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Меморандум и Устав

    13 страницыMA

    Полное погашение обременения 022500220018

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 022500220019

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 022500220017

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 022500220020

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 022500220021

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 022500220022

    1 страницыMR04

    Регистрация обременения 022500220023, создано 06 мая 2022 г.

    40 страницыMR01

    Юридический адрес изменен с 3 Fitzhardinge Street London W1H 6EF England на 50 Marshall Street C/O Newcore Capital Management Llp London W1F 9BQ 05 авг. 2021 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    17 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 13 июл. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Все имущество или предприятие освобождены и больше не являются частью обременения 022500220021

    1 страницыMR05

    Изменение данных секретаря для Newcore Capital Management Llp 01 янв. 2021 г.

    1 страницыCH04

    Прекращение полномочий Hugo William John Llewelyn в качестве директора 10 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Alexandra Clare Houghton на должность директора 09 сент. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    NEWCORE CAPITAL MANAGEMENT LLP
    Marshall Street
    W1F 9BQ London
    50
    England
    Секретарь компании
    Marshall Street
    W1F 9BQ London
    50
    England
    Организационно-правовая формаLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Тип идентификацииДругое юридическое лицо или фирма
    Юридическое основаниеLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Регистрационный номерOC368756
    189385590001
    HOUGHTON, Alexandra Clare
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    Директор
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    EnglandEnglishChartered Surveyor274204580001
    NEWCOMBE, Robert William
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    Директор
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    EnglandBritishBarrister61763650007
    NOTTINGHAM, Mathew Paul
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    Секретарь
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant21753020003
    SEDGWICK, John Michael
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    Секретарь
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    British14084690001
    LLEWELYN, Hugo William John
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    Директор
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    EnglandBritishFund Manager163647930001
    NEWCOMBE, Edward Mark
    Bakersgate Ash Road
    Pirbright
    GU24 0NA Woking
    Surrey
    Директор
    Bakersgate Ash Road
    Pirbright
    GU24 0NA Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor14084700002
    NEWCOMBE, John Langton
    39 Manor Road
    EN5 2JQ Barnet
    Hertfordshire
    Директор
    39 Manor Road
    EN5 2JQ Barnet
    Hertfordshire
    BritishSolicitor14084710001
    NOTTINGHAM, Mathew Paul
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    Директор
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Secretary21753020003
    SEDGWICK, John Michael
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    Директор
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    BritishCompany Director14084690001
    SIMON, Timothy John Adams
    GL54 2PN Wyck Rissington
    Maces Cottage
    Gloucestershire
    Директор
    GL54 2PN Wyck Rissington
    Maces Cottage
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director2325840002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    06 апр. 2016 г.
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииUk
    Юридическое основаниеCompany Law
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер86894
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 20 дек. 2023 г.
    Поставлен 20 дек. 2023 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as units 1-3 wessex industrial estate, bourne end, buckinghamshire, SL8 5DT registered at hm registry with title number BM117411. The freehold property known as millbrook service station, millbrook road west, southampton, SO15 0JU registered at hm registry with title number HP651779.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 20 дек. 2023 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 06 мая 2022 г.
    Поставлен 10 мая 2022 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The freehold land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge TN12 5HH as registered at the land registry under title number K868993. The freehold land and buildings on the east side of netham road, st annes, bristol BS5 9PQ as registered at the land registry under title numbers BL54825, BL83015 and BL103480. The freehold property known as 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title numbers AV61758 and AV193568. The lease of the land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge TN12 5HH as registered at the land registry under title number TT30938. The lease of the land and buildings on the east side of netham road, st annes, bristol BS5 9PQ as registered at the land registry under title number BL140293. The lease of 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title number BL147664. The lease of 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title number BL141363.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 10 мая 2022 г.Регистрация залога (MR01)
    • 27 июл. 2023 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 28 дек. 2017 г.
    Поставлен 08 янв. 2018 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as units 10-15 petersfield business park, hampshire, GU32 3QA registered at the land registry under title number HP397013. The leasehold property known as 1ST, 2ND and 3RD floors, 11/12 westgate buildings, bath, BA1 1EB registered at the land registry under title number ST297684. For more details of the other land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 08 янв. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 07 авг. 2018 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 17 авг. 2017 г.
    Поставлен 24 авг. 2017 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold land and buildings known as block a, new bond house, bond street, bristol BS2 9AG and registered at the land registry with title numbers AV77524, BL30149, BL28055, BL37276 and BL34368. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 24 авг. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 23 июл. 2021 г.Все имущество или предприятие освобождено и больше не является частью залога (MR05)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 29 мар. 2017 г.
    Поставлен 31 мар. 2017 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold land and buildings known as 11, 11A and 12 westgate street, bath BA1 1EQ and registered at the land registry with title number ST285187. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 31 мар. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 29 сент. 2016 г.
    Поставлен 04 окт. 2016 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge, TN12 5HH registered at the land registry with title number K868993. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 04 окт. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 12 мая 2016 г.
    Поставлен 13 мая 2016 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Carbase, netham road, bristol BS5 9PQ and auto centre, 118 blackswarth road, bristol BS5 8AG.
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 13 мая 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 01 июл. 2015 г.
    Поставлен 03 июл. 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Land including f/h units 10-15 petersfield business park hampshire t/no HP397013.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 03 июл. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 мая 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 22 июн. 2010 г.
    Поставлен 09 июл. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Property k/a land on the north west side of homefield road, haverhill t/no SK322017 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Транзакции
    • 09 июл. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 10 нояб. 2005 г.
    Поставлен 23 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Land k/a phase 1, homefield road, haverhill, suffolk t/no SK250706, and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleaeses tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge all the other property assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Транзакции
    • 23 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 19 окт. 2005 г.
    Поставлен 02 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The rotunda ware road hertford t/no HD280798 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    Транзакции
    • 02 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 19 окт. 2005 г.
    Поставлен 02 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings on the north side of parkhouse road newcastle under lyme t/no SF171912 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    Транзакции
    • 02 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal mortgage
    Создан 19 окт. 2005 г.
    Поставлен 02 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings on the north west side of gilcar way and unit b gilcar way valencia park wakefield t/nos WYK664813 and WYK652782 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    Транзакции
    • 02 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Memorandum of security over cash deposits
    Создан 19 окт. 2005 г.
    Поставлен 20 окт. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    First fixed charge the deposit and each and every debt represented by the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Транзакции
    • 20 окт. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of charge over securities
    Создан 16 дек. 2002 г.
    Поставлен 20 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company (or any person who is a party to any related security document) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All the issued share capital of friars house investments (telford) limited, being 1 ordinary share of £1 each, any other shares stocks securities, interest dividends bonus issues.... See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 20 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мая 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Supplemental legal charge
    Создан 16 дек. 2002 г.
    Поставлен 20 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H land being the rotunda ware road hertford in the county of hertfordshire t/n HD280798 and all buildings fixtures fittings.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 20 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мая 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage debenture
    Создан 21 дек. 2001 г.
    Поставлен 10 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All that f/h land and buildings on the north west side of gilcar way wakefield title absolute t/n WYK664813, unit b gilcar way valencia park wakefield title absolute t/n WYK652782 (for further details please see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 10 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мая 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Memorandum of security
    Создан 11 февр. 1992 г.
    Поставлен 14 февр. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All amounts from time to time standing to the credit of the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken
    Транзакции
    • 14 февр. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment by way of security.
    Создан 14 дек. 1990 г.
    Поставлен 03 янв. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 15/11/90.
    Краткое описание
    Agreement dated 13TH december 1990 between friars house investments limited and midland bank PLC in respect of an interest rate cap.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken
    Транзакции
    • 03 янв. 1991 г.Регистрация залога
    • 27 дек. 2001 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 24 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Floating charge
    Создан 14 дек. 1990 г.
    Поставлен 21 дек. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Liabilities on a full and unlimited indemnity basis. Together in each of the cases mentioned herein with all interest being computed in each such case according to the usual mode of the bank so that interest shall be payable at the same rate as well as before judgement.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handlesbanken PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1990 г.Регистрация залога
    • 27 дек. 2001 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 11 февр. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 14 дек. 1990 г.
    Поставлен 21 дек. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All that f/h property situate at and known as friars house warwick road coventry under title number: wm 469509.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1990 г.Регистрация залога
    • 27 дек. 2001 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 24 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment by way of security
    Создан 14 дек. 1990 г.
    Поставлен 21 дек. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £5,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a contractural agreement dated 13/12/1990
    Краткое описание
    An agreement dated 13 december 1990 between friars house investments limited and midland montagu in respect of an interest rate cap.
    Уполномоченные лица
    • Svenska Handelsbanken PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1990 г.Регистрация залога
    • 27 дек. 2001 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 24 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Floating charge
    Создан 07 июн. 1989 г.
    Поставлен 19 июн. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All the undertaking, property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 19 июн. 1989 г.Регистрация залога
    Legal charge
    Создан 24 апр. 1989 г.
    Поставлен 08 мая 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Friars house at the junction of warwick road and ringway point patricks, coventry, west midlands title no wm 469509.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 08 мая 1989 г.Регистрация залога
    • 14 июл. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0