POOLE INVESTMENTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииPOOLE INVESTMENTS LIMITED
    Статус компанииВ управлении
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02282021
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    • Аренда и эксплуатация недвижимости жилищных ассоциаций (68201) / Операции с недвижимым имуществом
    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Юридический адрес
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    POOLE INVESTMENTS PLC22 окт. 2004 г.22 окт. 2004 г.
    PILKINGTON'S TILES GROUP PLC18 авг. 1998 г.18 авг. 1998 г.
    QUILIGOTTI PLC27 февр. 1989 г.27 февр. 1989 г.
    FALLRACE LIMITED29 июл. 1988 г.29 июл. 1988 г.

    Каковы последние отчеты POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается30 сент. 2022 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июн. 2023 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2021 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    ПросроченоДа
    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на17 июл. 2024 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено31 июл. 2024 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на17 июл. 2023 г.
    ПросроченоДа

    Какие последние документы подавались POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Отчет о ходе администрации

    24 страницыAM10
    YDFRZQ5V

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19
    YDA2GN2R

    Отчет о ходе администрации

    23 страницыAM10
    YD1DYEA0

    Результат собрания кредиторов

    5 страницыAM07
    YCIEXFUJ

    Заявление о предложениях администратора

    50 страницыAM03
    YCHCN3B8

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA

    10 страницыAM02
    YCHCKIQP

    Юридический адрес изменен с Burnham Yard London End Beaconsfield HP9 2JH England на 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU 17 окт. 2023 г.

    2 страницыAD01
    YCDRANPF

    Назначение администратора

    3 страницыAM01
    YCDRAN3C

    Прекращение полномочий Nishith Malde в качестве директора 04 сент. 2023 г.

    1 страницыTM01
    XCBT1WBP

    Прекращение полномочий Desmond Richard Wicks в качестве директора 04 авг. 2023 г.

    1 страницыTM01
    XC9NTQCR

    Назначение Mr Jolyon Leonard Harrison на должность директора 24 июл. 2023 г.

    2 страницыAP01
    XC94YAG1

    Уведомление о подтверждении, составленное 17 июл. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XC8OJUQR

    Полное погашение обременения 022820210018

    1 страницыMR04
    XC651RB5

    Прекращение полномочий Sally Kenward в качестве секретаря 10 февр. 2023 г.

    1 страницыTM02
    XBX144JD

    Прекращение полномочий Donagh O'sullivan в качестве директора 16 янв. 2023 г.

    1 страницыTM01
    XBVDQ3UY

    Назначение Mr Donagh O'sullivan на должность директора 06 дек. 2022 г.

    2 страницыAP01
    XBIVEJ2J

    Назначение Mr Desmond Richard Wicks на должность директора 14 окт. 2022 г.

    2 страницыAP01
    XBFLBINL

    Прекращение полномочий Stephen Desmond Wicks в качестве директора 30 сент. 2022 г.

    1 страницыTM01
    XBE102JT

    Назначение Mrs Sally Kenward на должность секретаря 26 сент. 2022 г.

    2 страницыAP03
    XBDHQK8Y

    Прекращение полномочий Nishith Malde в качестве секретаря 26 сент. 2022 г.

    1 страницыTM02
    XBDHQJRF

    Назначение Mr Nishith Malde на должность секретаря 15 авг. 2022 г.

    2 страницыAP03
    XBAR0S00

    Прекращение полномочий Kathryn Worth в качестве секретаря 15 авг. 2022 г.

    1 страницыTM02
    XBAR0RW0

    Уведомление о подтверждении, составленное 17 июл. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01
    XB8O3U5S

    Годовая бухгалтерская отчетность

    26 страницыAA
    AB1QCND4

    Прекращение полномочий Gary John Skinner в качестве директора 05 апр. 2022 г.

    1 страницыTM01
    XB1DG1E9

    Кто является должностными лицами POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HARRISON, Jolyon
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Директор
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishDirector235132810001
    BEARDMORE, John Denis
    8 Oakley Close
    CW11 1RQ Sandbach
    Cheshire
    Секретарь
    8 Oakley Close
    CW11 1RQ Sandbach
    Cheshire
    BritishAccountant33971260001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Секретарь
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    BritishDirector118171450001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Секретарь
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director118171450001
    CAHILL, Thomas Gerard
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    Секретарь
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    BritishCompany Director32607500001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Секретарь
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Dir77855520001
    HYLAND, Melanie Patricia
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    227999990001
    KENWARD, Sally
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Секретарь
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    300527560001
    MALDE, Nishith
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Секретарь
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    299267920001
    MALDE, Nishith
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    Секретарь
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    BritishDirector148459300001
    QUINLAN, Michael John
    19 Old Church Lane
    Kingsbury
    NW9 8TG London
    Секретарь
    19 Old Church Lane
    Kingsbury
    NW9 8TG London
    British5570260001
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Секретарь
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    BritishDirector127918950001
    WORTH, Kathryn
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Секретарь
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    258014030001
    ALLAN, William Campbell
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    Директор
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    EnglandBritishChartered Accountant84460001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Директор
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector118171450001
    BRASSINGTON, Jeremy Guy
    Hightrees Wood Riding
    Pyrford Woods
    GU22 8RH Woking
    Surrey
    Директор
    Hightrees Wood Riding
    Pyrford Woods
    GU22 8RH Woking
    Surrey
    BritishCompany Director35912620002
    BRETT, Paul Richard
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    Директор
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector105377400002
    CAHILL, Thomas Gerard
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    Директор
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    BritishCompany Director32607500001
    CICUREL, David Elie
    18 Cavendish Avenue
    NW8 9JE London
    Директор
    18 Cavendish Avenue
    NW8 9JE London
    EnglandBritishCompany Director70056130003
    CROWTHER, Ian
    8 Stanneybrook Close
    Norley
    WA6 8PZ Cheshire
    Директор
    8 Stanneybrook Close
    Norley
    WA6 8PZ Cheshire
    BritishDirector31205800002
    DOVE, Michael Leslie
    Dales Lodge 10 Oldfield Gardens
    Heswall
    L60 6TG Wirral
    Merseyside
    Директор
    Dales Lodge 10 Oldfield Gardens
    Heswall
    L60 6TG Wirral
    Merseyside
    BritishCompany Director12007310001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Директор
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    AustralianDirector28868820001
    FENHALLS, Richard Dorian
    15
    St James Gardens
    W11 4RE London
    Директор
    15
    St James Gardens
    W11 4RE London
    BritishDirector33917200001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Директор
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Dir77855520001
    HODGSON, Kenneth Reid Theophilus
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Директор
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director4467930001
    HORNER, David Alistair
    90 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    Директор
    90 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    BritishCompany Director79690220001
    HUGHES, Mary-Lorraine, Dr
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    Директор
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector67402160001
    JENKINS, Roy Hunter, Dr
    Hale Road
    Hale Barns
    WA15 8TG Altrincham
    Ivy House, 367
    Директор
    Hale Road
    Hale Barns
    WA15 8TG Altrincham
    Ivy House, 367
    United KingdomBritishDirector134130590001
    JOHNSON, David Charles
    6 Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    England
    Директор
    6 Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    England
    BritishDirector42175350001
    KALBORG, Ted Gunnar Christer
    22 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Директор
    22 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    EnglandSwedishDirector8637550001
    MALDE, Nishith
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Директор
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    EnglandBritishDirector148459300001
    MCENHILL, Raymond Peter
    Burroughs Hill Duck Lane
    Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Директор
    Burroughs Hill Duck Lane
    Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director54190500001
    O'SULLIVAN, Donagh
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Директор
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    EnglandIrishChief Executive189234530001
    PAINE, Robert Arthur
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    Директор
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    EnglandBritishDirector53861730001
    PALMER, Horace Anthony
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Директор
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector45646020002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Inland Homes Plc
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    England
    06 апр. 2016 г.
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    England
    Да
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Юридическое основаниеCompanies Acts
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    06 апр. 2016 г.
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Страна регистрацииEnglad
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер08775582
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у POOLE INVESTMENTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 08 февр. 2022 г.
    Поставлен 14 февр. 2022 г.
    Не погашен
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Eric John Spencer Gadsden
    Транзакции
    • 14 февр. 2022 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 30 окт. 2020 г.
    Поставлен 12 нояб. 2020 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Ground floor unit, read house, stabler way, poole BH15 4FA (title number: DT436416). For further details of properties charged, please see schedule 2 of the deed.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mct (Properties) Limited
    Транзакции
    • 12 нояб. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 29 окт. 2020 г.
    Поставлен 29 окт. 2020 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Land forming part of land lying to the north east of blandford road, poole, BH15 4AR shown edged red on the plan attached to the charge and registered at H.M. land registry as title number DT413396.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • W E Black Finance Limited
    Транзакции
    • 29 окт. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 20 дек. 2019 г.
    Поставлен 03 янв. 2020 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Land forming part of the former pilkingtons tiles LTD, blandford road, poole, BH15 4AR registered at H.M. land registry under title number DT235032 and DT302424.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • W. E. Black Finance Limited
    Транзакции
    • 03 янв. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 20 дек. 2019 г.
    Поставлен 02 янв. 2020 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Land forming part of the former pilkingtons tiles LTD, blandford road, poole, BH15 4AR registered at H.M. land registry under title numbers DT235032 and DT302424.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • W. E. Black Finance Limited
    Транзакции
    • 02 янв. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 28 июн. 2019 г.
    Поставлен 16 июл. 2019 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Inland Zdp PLC
    Транзакции
    • 16 июл. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    • 21 июн. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 28 июн. 2019 г.
    Поставлен 16 июл. 2019 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Inland Zdp PLC
    Транзакции
    • 16 июл. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    • 07 февр. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 19 июн. 2018 г.
    Поставлен 02 июл. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Part of land at pilkingtons tiles limited, blandford road, poole, dorset BH15 4AR registered at the land registry under freehold title number DT235032.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mct (Properties) Limited
    Транзакции
    • 02 июл. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 01 июл. 2016 г.
    Поставлен 06 июл. 2016 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as or being part of. Carters quay, poole, BH15 4AR and registered at. Land registry with title number DT235032.. Please see charge instrument for detail of further. Property.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 06 июл. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 21 июн. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 30 июн. 2015 г.
    Поставлен 01 июл. 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Park house, 38 station road, loudwater HP10 9UF - title number BM22498.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Close Brothers Limited
    Транзакции
    • 01 июл. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 янв. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 06 мар. 2015 г.
    Поставлен 19 мар. 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    O-bit house, station road, loudwater HP10 9UF - title number BM22498.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Close Brothers Limited
    Транзакции
    • 19 мар. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 янв. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 28 июн. 2013 г.
    Поставлен 04 июл. 2013 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    DT235032 and DT302424 poole: land at blandford road poole dorset but excluding the land shown edged red on the plan annexed to the supplemental security deed and 28 blandford road poole dorset.
    Уполномоченные лица
    • Inland Zdp PLC
    Транзакции
    • 04 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 янв. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 29 окт. 2009 г.
    Поставлен 03 нояб. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings at lower hamworthy t/n DT235032, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 03 нояб. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 10 февр. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 29 окт. 2009 г.
    Поставлен 03 нояб. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    28 blandford road poole t/n DT302424, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 03 нояб. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 10 февр. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 09 июн. 2009 г.
    Поставлен 12 июн. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 12 июн. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 28 мая 2004 г.
    Поставлен 09 июн. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a land and buildings at lower hamworthy poole t/no DT235032 floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment present and future.
    Уполномоченные лица
    • The Co-Operative Bank PLC
    Транзакции
    • 09 июн. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 мар. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 28 мая 2004 г.
    Поставлен 08 июн. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property k/a 28 blandford road, poole, dorset t/n:DT302424 and the f/h property k/a land and buildings at lower hamworthy, poole, dorset t/n:DT235032. By way of fixed charge all fixtures and fixed plant, machinery and equipment, the benefit to the company of all covenants, rights and agreements.
    Уполномоченные лица
    • Kevin Whiteley
    Транзакции
    • 08 июн. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 мар. 2013 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 28 мая 2004 г.
    Поставлен 04 июн. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    28 blandford road poole t/no DT302424 floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment present and future.
    Уполномоченные лица
    • The Co-Operative Bank PLC
    Транзакции
    • 04 июн. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 мар. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 09 февр. 2004 г.
    Поставлен 14 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Транзакции
    • 14 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июн. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 февр. 2004 г.
    Поставлен 11 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Co-Operative Bank PLC
    Транзакции
    • 11 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июн. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 18 мар. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Создан 18 июл. 1997 г.
    Поставлен 06 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The deposit initially of £1,804,782 credited to account/designation 20133764 with the bank and any addition to that deposit.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 06 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 янв. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 18 июл. 1997 г.
    Поставлен 30 июл. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 30 июл. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 февр. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 08 дек. 1989 г.
    Поставлен 21 дек. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1989 г.Регистрация залога
    • 28 нояб. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у POOLE INVESTMENTS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    05 окт. 2023 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Philip Lewis Armstrong
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    David Paul Hudson
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0