GERRARD (OMH) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGERRARD (OMH) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02284499
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GERRARD (OMH) LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится GERRARD (OMH) LIMITED?

    Юридический адрес
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GERRARD (OMH) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    OLD MUTUAL HOLDINGS LIMITED11 нояб. 2002 г.11 нояб. 2002 г.
    OLD MUTUAL SECURITIES LIMITED01 июн. 2000 г.01 июн. 2000 г.
    ALBERT E SHARP LIMITED01 янв. 1995 г.01 янв. 1995 г.
    ALBERT E. SHARP & CO.05 авг. 1988 г.05 авг. 1988 г.

    Каковы последние отчеты GERRARD (OMH) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2015 г.

    Какие последние документы подавались GERRARD (OMH) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    11 страницыLIQ13

    Юридический адрес изменен с 1 Churchill Place London E14 5HP на Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR 27 февр. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Назначение ликвидатора

    2 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 09 февр. 2017 г.

    LRESSP

    legacy

    2 страницыSH20

    Отчет о капитале на 07 февр. 2017 г.

    • Капитал: GBP 1.05
    3 страницыSH19

    legacy

    2 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Share premium of £275,767.00 is cancelled 06/02/2017
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Полное погашение обременения 5

    4 страницыMR04

    Уведомление о подтверждении, составленное 09 дек. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 янв. 2016 г.

    Отчет о капитале на 20 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Назначение Dr Philip Andrew Frank Byle на должность директора 19 июн. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mark Andrew Richards на должность директора 19 июн. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Nicholas John Garnett в качестве директора 22 апр. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 янв. 2015 г.

    Отчет о капитале на 20 янв. 2015 г.

    • Капитал: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital08 янв. 2014 г.

    Отчет о капитале на 08 янв. 2014 г.

    • Капитал: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Назначение Mr Richard Henry Philipps на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David Currie в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Кто является должностными лицами GERRARD (OMH) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Секретарь компании
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    BYLE, Philip Andrew Frank, Dr.
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Директор
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish175463080001
    PHILIPPS, Richard Henry
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178406100001
    RICHARDS, Mark Andrew
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Директор
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish182116990001
    FISHER, Peter Blake
    Old Ridgeway Cottage
    Crown Lane Wychbold
    WR9 0BX Droitwich
    Worcestershire
    Секретарь
    Old Ridgeway Cottage
    Crown Lane Wychbold
    WR9 0BX Droitwich
    Worcestershire
    British25278500001
    HILL, Edwina Anne
    27 Bishops Meadow
    Weeford Road
    B75 5PQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Секретарь
    27 Bishops Meadow
    Weeford Road
    B75 5PQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44399680002
    MAYOR, Sukesh Chander
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    Секретарь
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    British72392270001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    92 Stratton Drive
    IG11 9HD Barking
    Essex
    Секретарь
    92 Stratton Drive
    IG11 9HD Barking
    Essex
    British55097590002
    SMELLIE, Keith Graham
    South Lawn
    CV35 7AA Rowington
    Warwick
    Секретарь
    South Lawn
    CV35 7AA Rowington
    Warwick
    British97352560001
    SUTTON, Ian Nicholas
    83a Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    Секретарь
    83a Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    British37516040002
    TELFER, Miranda Lauraine
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    Секретарь
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    British80083220001
    AIREY, Christopher Jonathan
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    Директор
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    British45740380001
    ANSTEE, Eric Edward
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    Директор
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish76479900001
    ATKINSON, Kevin Derek
    Stanage
    Roslyn Road, Wellington
    TF1 3AX Telford
    Shropshire
    Директор
    Stanage
    Roslyn Road, Wellington
    TF1 3AX Telford
    Shropshire
    EnglandBritish97538420001
    AUSTIN, Richard Graham Gosset
    Olde Timbers Pumphouse Lane
    Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    Директор
    Olde Timbers Pumphouse Lane
    Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    British3533270001
    BARON, Rupert Nigel Kendall
    2 Rectory Road
    SW13 0DT London
    Директор
    2 Rectory Road
    SW13 0DT London
    British30084840002
    BARRELL, Alexander Conan
    Skinners Hill Cottage Eyford Park
    Upper Slaughter
    GL54 2JN Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Skinners Hill Cottage Eyford Park
    Upper Slaughter
    GL54 2JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British59253480001
    BARRETT, Del Amanda, Dr
    102a Marlborough
    61 Walton Street
    SW3 2JY London
    Директор
    102a Marlborough
    61 Walton Street
    SW3 2JY London
    EnglandBritish39721540001
    BAWDEN, Derek Charles
    The Cottage 65 Water Lane
    NN4 6HH Wootton
    Northampton
    Директор
    The Cottage 65 Water Lane
    NN4 6HH Wootton
    Northampton
    British59367250001
    BENNETT, Timothy Michael Roth
    62 Sir Johns Road
    B29 7ER Selly Park
    Birmingham
    Директор
    62 Sir Johns Road
    B29 7ER Selly Park
    Birmingham
    British70298090001
    BERNAYS, Richard Oliver
    82 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Директор
    82 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish98729980001
    BLATCHLY, Christopher Nigel
    Old Comptons
    Comptons Lane
    RH13 6DP Horsham
    West Sussex
    Директор
    Old Comptons
    Comptons Lane
    RH13 6DP Horsham
    West Sussex
    British26871210002
    BLOUNT, Christopher
    Cornerways
    The Green, Leafield
    OX29 9NP Witney
    Oxfordshire
    Директор
    Cornerways
    The Green, Leafield
    OX29 9NP Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish89344930001
    BOGLE, Robert Oswald
    31 Foley Road East
    Streetly
    B74 3HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Директор
    31 Foley Road East
    Streetly
    B74 3HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British6832140001
    BOLSOVER, Michael Timothy
    Wakehurst
    Limes Close Bramshott
    GU30 7SL Liphook
    Hampshire
    Директор
    Wakehurst
    Limes Close Bramshott
    GU30 7SL Liphook
    Hampshire
    EnglandBritish104281460001
    BROCKLEBANK, Roger James
    Nursery Cottage Bull Hill Lane
    Astley Burf
    DY13 0SE Stourport On Severn
    Worcestershire
    Директор
    Nursery Cottage Bull Hill Lane
    Astley Burf
    DY13 0SE Stourport On Severn
    Worcestershire
    British44399140001
    CAMPBELL, Gordon Edward
    34 Inchford Road
    B92 9QD Solihull
    West Midlands
    Директор
    34 Inchford Road
    B92 9QD Solihull
    West Midlands
    British6832150001
    CAMPBELL, Neil
    Forge Cottage
    Street End
    BS40 7TL Blaydon
    Bristol
    Директор
    Forge Cottage
    Street End
    BS40 7TL Blaydon
    Bristol
    United KingdomBritish59407690001
    CAMPBELL, Norman Hunter
    31 Montgomery Street
    G76 0AS Eaglesham
    Директор
    31 Montgomery Street
    G76 0AS Eaglesham
    ScotlandBritish10030001
    CASHDAN, David
    11 Walsingham
    St Johns Wood Park
    NW8 6RG London
    Директор
    11 Walsingham
    St Johns Wood Park
    NW8 6RG London
    British34609460001
    CASSIE, John
    12 Barn Road
    Handsacre
    WS15 4TA Rugeley
    Staffordshire
    Директор
    12 Barn Road
    Handsacre
    WS15 4TA Rugeley
    Staffordshire
    British85363490001
    CONDER, Simon Andrew
    Elizabeth Dane
    5c Burnt Ash Lane
    BR1 4DJ Bromley
    Kent
    Директор
    Elizabeth Dane
    5c Burnt Ash Lane
    BR1 4DJ Bromley
    Kent
    United KingdomBritish87427400001
    COOKE, Trevor Charles
    Clifton Cottage Cliftons Lane
    RH2 9RA Reigate
    Surrey
    Директор
    Clifton Cottage Cliftons Lane
    RH2 9RA Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish141581640001
    CULL, Graeme Frank
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    Директор
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    British62391710001
    CURRIE, David Mclean
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Директор
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    ScotlandBritish136790250001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над GERRARD (OMH) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06 апр. 2016 г.
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland & Wales
    Юридическое основаниеEngland And Wales
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер2181315
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у GERRARD (OMH) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Security deed
    Создан 26 июн. 2000 г.
    Поставлен 05 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 05 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 нояб. 2003 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 06 февр. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security deed
    Создан 01 февр. 2000 г.
    Поставлен 15 февр. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including, without limitation, in connection with the facility agreement; any assured payment by the chargee; or any transfer of stock to the company by means of crest; or any agreement to transfer stock to the company by means of crest; or any issue of stock to the company by means of crest
    Краткое описание
    First fixed charge all sums and payments hereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit stock for any eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 15 февр. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Создан 23 июл. 1998 г.
    Поставлен 03 авг. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from albert e sharp holdings PLC to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Краткое описание
    30802964. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 03 авг. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 13 апр. 1993 г.
    Поставлен 20 апр. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due under the terms of the charge
    Краткое описание
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Транзакции
    • 20 апр. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 нояб. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment
    Создан 09 июл. 1992 г.
    Поставлен 16 июл. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys due or owing due as specified in the guarantee dated 9TH july 1992 see form 395 ref. M249C for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 июл. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 окт. 1992 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у GERRARD (OMH) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    09 февр. 2017 г.Начало ликвидации
    22 сент. 2017 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0