COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCOUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02295319
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    • Розничная торговля новыми легковыми автомобилями (45111) / Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
    • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45200) / Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

    Где находится COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Юридический адрес
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    VEHICLE DISPOSAL LIMITED08 мар. 1990 г.08 мар. 1990 г.
    AXBRIDGE INVESTMENTS LIMITED31 янв. 1989 г.31 янв. 1989 г.
    HACKREMCO (NO.423) LIMITED13 сент. 1988 г.13 сент. 1988 г.

    Каковы последние отчеты COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2011 г.

    Какие последние документы подавались COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Robert William Guy Whitrow в качестве директора 02 окт. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Roger Graham Partridge в качестве директора 28 сент. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital21 авг. 2012 г.

    Отчет о капитале на 21 авг. 2012 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Юридический адрес изменен с Crowthorne House Nine Mile Road Wokingham Berkshire RG40 3GA 30 мар. 2012 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    legacy

    11 страницыMG01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен

    1 страницыAD02

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Назначение Robert William Guy Whitrow на должность директора

    3 страницыAP01

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    Изменение данных директора для Roger Graham Partridge 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для David Alan Bird 01 окт. 2009 г.

    1 страницыCH03

    Изменение данных директора для David Alan Bird 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Roderick Neil Graham 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Кто является должностными лицами COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BIRD, David Alan
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    British89738470001
    BIRD, David Alan
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89738470001
    GRAHAM, Roderick Neil
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51466570002
    DEAN, Julian Mark
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    Секретарь
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    British47136600002
    MCCALL, William
    Arngibbon House
    FK8 3ES Kippen
    Stirlingshire
    Секретарь
    Arngibbon House
    FK8 3ES Kippen
    Stirlingshire
    BritishDirector39902920003
    MORRISON, Audrey
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    Секретарь
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    British44972470001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Секретарь
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British7680750001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Секретарь
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British7680750001
    SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    Секретарь
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    British110050670001
    STALKER, Christopher David
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    Секретарь
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    BritishDirector75389440001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Секретарь
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    British45988970001
    JOHNSTON, Anthony Maurice
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    Директор
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    EnglandBritishDirector91243020001
    MCCOMB, Robert Wilson
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    Директор
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    United KingdomBritishMerchant Banker13929280001
    MCRAE, Michael John Standing
    The Berries
    Westmill
    SG9 9LL Buntingford
    Hertfordshire
    Директор
    The Berries
    Westmill
    SG9 9LL Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector52779060001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant7680750001
    PARTRIDGE, Roger Graham
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    BerkshireBritishDirector84959730003
    STALKER, Christopher David
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    Директор
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    EngalndBritishAccountant75389440001
    STEAD, Nigel Cleator
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    Директор
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director47582470001
    STEPHENS, Nigel Charles
    Forest House 61 Chertsey Road
    GU20 6HE Windlesham
    Surrey
    Директор
    Forest House 61 Chertsey Road
    GU20 6HE Windlesham
    Surrey
    BritishCompany Director1680570001
    VOSS, David Anthony Henry
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishGeneral Manager6551300002
    WHITE, Andrew John
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    Директор
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    BritishBanker8107360001
    WHITROW, Robert William Guy
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector83349560001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Директор
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish45988970001

    Есть ли у COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 05 янв. 2011 г.
    Поставлен 07 янв. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Santander Asset Finance PLC (Creditor)
    Транзакции
    • 07 янв. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 29 авг. 2008 г.
    Поставлен 05 сент. 2008 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H interest in the property k/a office suites 1 and 2 first floor guildgate house high street crowthorne berkshire t/no BK261879,l/h interest in the property k/a regal house station road marlow t/no BM245030,l/h interest in the property k/a part second floor crowthorne house nine mile ride crowthorne t/no BK394247 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Транзакции
    • 05 сент. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 20 дек. 2006 г.
    Поставлен 22 дек. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC as Agent Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Транзакции
    • 22 дек. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 сент. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 08 дек. 1999 г.
    Поставлен 24 дек. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 24 дек. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0