BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBROOKSIDE PRODUCTS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02355643
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    • Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (10200) / Обрабатывающая промышленность
    • Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах (47230) / Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

    Где находится BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Dwf Llp 1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BROOKSIDE FARM PRODUCTS LIMITED 06 мар. 1989 г.06 мар. 1989 г.

    Каковы последние отчеты BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Какие последние документы подавались BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Andrew William Stapley в качестве директора 31 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 10

    5 страницыMR04

    Назначение James Richard Edward Charles Mark на должность директора 24 мар. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Sabina Elisabeth Clementina Odilia Goertz в качестве директора 10 мар. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Maiko Van De Meer в качестве директора 21 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Olav Soleide на должность директора 24 мар. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital15 апр. 2016 г.

    Отчет о капитале на 15 апр. 2016 г.

    • Капитал: GBP 740,000
    SH01

    Прекращение полномочий Marc Constant Cornelia Claessens в качестве директора 07 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Sabina Elisabeth Clementina Odilia Goertz на должность директора 07 янв. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    18 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital21 апр. 2015 г.

    Отчет о капитале на 21 апр. 2015 г.

    • Капитал: GBP 740,000
    SH01

    Юридический адрес изменен с Harbour View Glasson Estate Maryport Cumbria CA15 8NT на C/O Dwf Llp 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA 04 февр. 2015 г.

    1 страницыAD01

    Назначение Mr Andrew William Stapley на должность директора 28 нояб. 2014 г.

    3 страницыAP01

    Прекращение полномочий Douglas Aitchison в качестве директора 02 окт. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    20 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital23 апр. 2014 г.

    Отчет о капитале на 23 апр. 2014 г.

    • Капитал: GBP 740,000
    SH01

    Назначение Maiko Van De Meer на должность директора

    3 страницыAP01

    Назначение Brodies Secretarial Services Limited на должность секретаря

    4 страницыAP04

    Прекращение полномочий Geoffrey Cormack в качестве директора

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Lc Secretaries Limited в качестве секретаря

    2 страницыTM02

    Назначение Marc Constant Cornelia Claessens на должность директора

    3 страницыAP01

    Прекращение полномочий John-Paul Mcginley в качестве директора

    4 страницыTM01

    Кто является должностными лицами BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Uk
    Секретарь компании
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Uk
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номерSC210264
    79799970001
    MARK, James Richard Edward Charles
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    Директор
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United KingdomBritishFinance Director207378990001
    SOLEIDE, Olav
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    Директор
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    NorwayNorwegianGlobal Sales Controller207379150001
    HODGSON, Richard Anthony
    West End Farm House
    Church Road Flimby
    CA15 8JT Maryport
    The Angelus
    Cumbria
    Секретарь
    West End Farm House
    Church Road Flimby
    CA15 8JT Maryport
    The Angelus
    Cumbria
    BritishDirector63881810005
    HODGSON, Rosemary
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    Секретарь
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    British11828920001
    WILSON, Phillip James
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    Секретарь
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    162705690001
    LC SECRETARIES LIMITED
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Секретарь компании
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номерSC299827
    112802860001
    AITCHISON, Douglas
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    Директор
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    ScotlandBritishChartered Accountant86803390001
    CLAESSENS, Marc Constant Cornelia
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    Директор
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    BelgiumBelgianFinance & It Director184926550001
    CORMACK, Geoffrey Beaton
    Victoria Street
    AB10 1PU Aberdeen
    17
    United Kingdom
    Директор
    Victoria Street
    AB10 1PU Aberdeen
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director179773840001
    GOERTZ, Sabina Elisabeth Clementina Odilia
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Midlothian
    United Kingdom
    Директор
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Midlothian
    United Kingdom
    NetherlandsDutchFinance & It Director206614040001
    HEYWOOD, Edward Alan, Doctor
    Brookside Farm House Row Brow
    Dearham
    CA15 7JR Maryport
    Cumbria
    Директор
    Brookside Farm House Row Brow
    Dearham
    CA15 7JR Maryport
    Cumbria
    EnglandBritishDoctor23405980003
    HEYWOOD, Eileen
    Brookside Farmhouse
    Dearham
    CA15 7JR Maryport
    Cumbria
    Директор
    Brookside Farmhouse
    Dearham
    CA15 7JR Maryport
    Cumbria
    EnglandBritishDirector54332520001
    HEYWOOD, John Andrew
    2 The Lea
    Pardshaw
    CA13 0SP Cockermouth
    Cumbria
    Директор
    2 The Lea
    Pardshaw
    CA13 0SP Cockermouth
    Cumbria
    EnglandBritishDirector54335930001
    HEYWOOD, Mark Alan
    3 Smithy Cottage
    Crosby
    CA15 6SP Maryport
    Cumbria
    Директор
    3 Smithy Cottage
    Crosby
    CA15 6SP Maryport
    Cumbria
    EnglandBritishSales Director47053660001
    HODGSON, David Robson
    24a Fleming Square
    CA15 6HQ Maryport
    Cumbria
    Директор
    24a Fleming Square
    CA15 6HQ Maryport
    Cumbria
    EnglandBritishProduction Director80998520003
    HODGSON, John Robson
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    Директор
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    EnglandBritishDirector11828940001
    HODGSON, Richard Anthony
    West End Farm House
    Church Road Flimby
    CA15 8JT Maryport
    The Angelus
    Cumbria
    Директор
    West End Farm House
    Church Road Flimby
    CA15 8JT Maryport
    The Angelus
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector63881810005
    HODGSON, Rosemary
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    Директор
    The Crescent
    Midtown Dearham
    CA15 7HQ Maryport
    Cumbria
    Great BritainBritishDirector11828920001
    MCGINLEY, John-Paul
    81-524
    Gdynia
    Swietopelka 19/26
    Poland
    Директор
    81-524
    Gdynia
    Swietopelka 19/26
    Poland
    PolandBritishManager154907800001
    STAPLEY, Andrew William
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    Директор
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director193649940001
    VAN DE MEER, Maiko
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    Директор
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    C/O Dwf Llp
    United Kingdom
    The NetherlandsDutchCeo184986180001
    WILSON, Phillip James
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    Директор
    Harbour View
    Glasson Estate
    CA15 8NT Maryport
    Cumbria
    United KingdomBritishFinance Director112303680002
    TIFFLE LIMITED
    Tiffle Bank
    Gallowbarrow
    LA12 0NR Hawkshead
    Cumbria
    Директор компании
    Tiffle Bank
    Gallowbarrow
    LA12 0NR Hawkshead
    Cumbria
    47053470001

    Есть ли у BROOKSIDE PRODUCTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    All assets debenture
    Создан 13 сент. 2011 г.
    Поставлен 17 сент. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Транзакции
    • 17 сент. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 30 июн. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Full form debenture
    Создан 09 дек. 2009 г.
    Поставлен 15 дек. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Leumi Abl Limited
    Транзакции
    • 15 дек. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 13 дек. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage
    Создан 20 авг. 2008 г.
    Поставлен 27 авг. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £176,531.71 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The items as listed on the schedule being - supplier: carnitech, description: cp party pack slicer IPS3000, serial number: 9348; carnitech, check weigher for IPS3000, 9512; unitech engineering, conveyors system and turntables together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together with all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation belonging to the above items see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 27 авг. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 дек. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 14 мар. 2002 г.
    Поставлен 26 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a plot c glasson industrial estate maryport cumbria t/n CU148619. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 26 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 апр. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 14 мар. 2002 г.
    Поставлен 21 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a harbour view glasson industrial estate maryport cumbria.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 21 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal mortgage
    Создан 30 июн. 1999 г.
    Поставлен 02 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Plot c glasson industrial estate harbour view maryport cumbria. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 02 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Создан 09 апр. 1999 г.
    Поставлен 16 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Краткое описание
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Уполномоченные лица
    • Griffin Credit Services Limited
    Транзакции
    • 16 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 14 окт. 1994 г.
    Поставлен 15 окт. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Plot c glasson industrial estate maryport cumbria. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 15 окт. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 19 апр. 1994 г.
    Поставлен 22 апр. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 22 апр. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 24 нояб. 1989 г.
    Поставлен 06 дек. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 06 дек. 1989 г.Регистрация залога
    • 17 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0