175 BISHOPSGATE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компании175 BISHOPSGATE LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02358667
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    • (7011) /

    Где находится 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    Юридический адрес
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BROADGATE (PHASE 8) LIMITED28 мар. 1989 г.28 мар. 1989 г.
    RINGFALL ESTATES LIMITED10 мар. 1989 г.10 мар. 1989 г.

    Каковы последние отчеты 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2009 г.

    Какие последние документы подавались 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    8 страницыAR01

    Отчет о капитале на 15 апр. 2010 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    Прекращение полномочий Sarah Barzycki в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Timothy Roberts в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Peter Clarke в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Graham Roberts в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Lucinda Bell в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Nigel Webb в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Anthony Braine в качестве директора

    1 страницыTM01

    Изменение данных секретаря для Ndiana Ekpo 01 окт. 2009 г.

    1 страницыCH03

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    Прекращение полномочий Andrew Jones в качестве директора

    1 страницыTM01

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    6 страницы363a

    legacy

    1 страницы288c

    Кто является должностными лицами 175 BISHOPSGATE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Секретарь
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Директор
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Секретарь
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Секретарь
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Секретарь
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Директор
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishDirector Of Companies2068480001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Директор
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Директор
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Директор
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BLACKBURN, David Michael
    Lansdowne Road
    W11 3AL London
    7
    Директор
    Lansdowne Road
    W11 3AL London
    7
    EnglandBritishDirector Of Companies67601540001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Директор
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Директор
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    Директор
    11 Walham Grove
    SW6 London
    BritishNew Business Director4807190002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Директор
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Директор
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishFinancial Director52294450003
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Директор
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishAssociate Director73961570001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Директор
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    BritishSolicitor36631180001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Директор
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Директор
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Директор
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    KERSHAW, Peter
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Директор
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    BritishDirector Of Companies51322410001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Директор
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritishDirector Of Companies2068540001
    MANNION, Michael John Francis
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    Директор
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCivil Engineer57126040001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Директор
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Директор
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Директор
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RIVLIN, Paul Denis
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    Директор
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    BritishDirector Of Companies2068550001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Директор
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Директор
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor63986410003
    ROGERS, Peter William
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Директор
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritishDirector Of Companies118055820001
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant1604580001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Директор
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    WINFIELD, Barry Chester
    The Old Stables Desborough Road
    Stoke Albany
    LE16 8PS Market Harborough
    Leicestershire
    Директор
    The Old Stables Desborough Road
    Stoke Albany
    LE16 8PS Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishProject Director36630390001

    Есть ли у 175 BISHOPSGATE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Group debenture
    Создан 23 нояб. 1992 г.
    Поставлен 01 дек. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "overide agreement" dated 23RD november 1992 and this charge
    Краткое описание
    See doc ref M101 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 01 дек. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 мар. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Charge reg pursuant to a court order d/d 24/08/90
    Создан 07 сент. 1990 г.
    Приобретен 31 мар. 1989 г.
    Поставлен 07 сент. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The aggregate at all the monies and liabilities due from rosehaugh stanhope (broadgate phase 8) PLC to the mortgagee and/or the banks(as defined) pursuant to a loan agreement dated 23.12.88 and/or the charge
    Краткое описание
    All the estate and interest of the tenant under the head lease (as defined) in the land, premises and airspace situated adjoining bishopsgate london EC2 and comprising the property k/as phase 8 broadgate (including part of exchange square) and including (where appropriate) all buildings and other structures. (Please see doc for full details).
    Уполномоченные лица
    • Natwest Investment Bank Limited
    Транзакции
    • 07 сент. 1990 г.Регистрация залога
    • 25 мар. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge reg pursuant to a court order d/d 24/08/90
    Создан 07 сент. 1990 г.
    Приобретен 31 мар. 1989 г.
    Поставлен 07 сент. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The secured sums as defined in an agreement dated 31.3.89
    Краткое описание
    Second legal charge all that l/hold property k/as phase 8 broadgate london EC2 by way of assignment and subject to rights of any prior assignee by way of security pursuant to the terms of the principal agreement. (Please see doc for full details).
    Уполномоченные лица
    • British Railways Board
    Транзакции
    • 07 сент. 1990 г.Регистрация залога
    • 25 мар. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Charge
    Создан 31 мар. 1989 г.
    Поставлен 11 апр. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys due or to become due from the company and/or ronchaugh stanhope (broadgate phase 8) PLC to natwest investment bank limited (as agent and trustee for the banks, as named in the deed) and/or the banks under or pursuant to the loan agreement dated 31/3/89 and any agreement in writing expressed to be supplemental thereto including (without limitation) an agreement and/or charge both dated 31/3/89 and/or this charge
    Краткое описание
    Land premises and airspace situated adjoining bishopsgate london EC2 in the city of london and comprising the property k/a phase 8 broadgate (including part of exchange square) with all buildings and other structures. (For full details of charged property please see form 395).
    Уполномоченные лица
    • Natwest Investment Bank Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    Транзакции
    • 11 апр. 1989 г.Регистрация залога
    • 25 мар. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0