EX HAMPS DEAC LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииEX HAMPS DEAC LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02396152
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель EX HAMPS DEAC LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Юридический адрес
    Portland
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED16 июн. 1989 г.16 июн. 1989 г.

    Каковы последние отчеты EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2011 г.

    Каков статус последней годовой декларации для EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    17 страницы4.71

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 05 нояб. 2014 г.

    12 страницы4.68

    Назначение ликвидатора

    2 страницы600

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации

    LRESSP

    Прекращение полномочий Ian Sutherland в качестве директора

    1 страницыTM01

    Юридический адрес изменен с * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* 14 нояб. 2013 г.

    2 страницыAD01

    Назначение Ian Ronald Sutherland на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Ian Sutherland в качестве директора

    1 страницыTM01

    Предыдущий отчетный период сокращен

    2 страницыAA01

    Текущий отчетный период сокращен

    3 страницыAA01

    Прекращение полномочий Michael Ramsey в качестве директора

    1 страницыTM01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13
    2 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name03 июн. 2013 г.

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Назначение Kevin Michael Withington на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital31 мая 2013 г.

    Отчет о капитале на 31 мая 2013 г.

    • Капитал: GBP 10,000
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Прекращение полномочий David Oliver в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Michael Francis Ramsey на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Изменение данных директора для Ian Ronald Sutherland 21 нояб. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Назначение Ian Ronald Sutherland на должность директора

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Кто является должностными лицами EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Секретарь
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    WITHINGTON, Kevin Michael
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    Директор
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    EnglandEnglish178721390001
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Секретарь
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    British148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Секретарь
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    British57752860001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Секретарь
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Секретарь
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DUCKER, Elaine
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    Секретарь
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    British12261980001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Секретарь
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Секретарь
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    British82018950001
    ZEALE, Nadine Catherine
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    Секретарь
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    British58435360001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    Секретарь
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    British22396670002
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Директор
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Директор
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish57752860001
    BOYD, Iain Grant
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    Директор
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    British51260620002
    CRAN, John Andrew George
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Директор
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish61456650002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Директор
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Директор
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30526830004
    DUCKER, David George Bartholomew
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    Директор
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    British45548190004
    DUCKER, David George Bartholomew
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    Директор
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    British45548190002
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Директор
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Директор
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Директор
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritish62622410007
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    Директор
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Директор
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish82018950001
    PEJNOVIC, Tomislav
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    Директор
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritish204966490001
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    Директор
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    PURKISS, Julie
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    Директор
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    British99182850001
    RAMSEY, Michael Francis
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    Директор
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United KingdomBritish80310620002
    SMITH, James Robert Drummond
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    Директор
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    SpainBritish130443150001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Директор
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163582690001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Директор
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    WILLIAMS, Neil Vaughan
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    Директор
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish71561050001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    Директор
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    British22396670003

    Есть ли у EX HAMPS DEAC LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Supplemental charge
    Создан 02 янв. 2008 г.
    Поставлен 08 янв. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    Транзакции
    • 08 янв. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июн. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Group debenture
    Создан 26 июл. 2006 г.
    Поставлен 03 авг. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Транзакции
    • 03 авг. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июн. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 06 мар. 2002 г.
    Поставлен 14 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Транзакции
    • 14 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company
    Создан 08 дек. 1999 г.
    Поставлен 18 дек. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 дек. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 22 дек. 1998 г.
    Поставлен 05 янв. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bhf-Bank Ag
    Транзакции
    • 05 янв. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 дек. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 12 сент. 1994 г.
    Поставлен 20 сент. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC,
    Транзакции
    • 20 сент. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 июн. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у EX HAMPS DEAC LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    2
    ДатаТип
    04 февр. 2016 г.Дата ликвидации
    06 нояб. 2013 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Практик
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Matthew Richard Meadley Wild
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Практик
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0