NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииNEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02449463
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Юридический адрес
    Halifax Avenue
    Fradley Park
    WS13 8SS Lichfield
    Staffordshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED23 апр. 1990 г.23 апр. 1990 г.
    TECHNICAL CONCEPTS EUROPE LIMITED05 дек. 1989 г.05 дек. 1989 г.

    Каковы последние отчеты NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    1 страницыDS01

    Назначение Mr. Brian James Decker на должность директора 23 янв. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Mark Weston Johnson в качестве директора 23 янв. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 янв. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 янв. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 янв. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Назначение Mr. Mark Weston Johnson на должность директора 31 мар. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Michael Richard Peterson в качестве директора 31 мар. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 янв. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Изменение данных директора для Michael Richard Peterson 18 апр. 2016 г.

    2 страницыCH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital08 янв. 2016 г.

    Отчет о капитале на 08 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital13 янв. 2015 г.

    Отчет о капитале на 13 янв. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    Изменение данных директора для Michael Richard Peterson 22 авг. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Michael Richard Peterson 22 авг. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital06 янв. 2014 г.

    Отчет о капитале на 06 янв. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed technical concepts international LIMITED\certificate issued on 02/04/13
    3 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    02 апр. 2013 г.

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Кто является должностными лицами NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    DECKER, Brian James, Mr.
    Peachtree Dunwoody Road
    30328 Atlanta
    6655
    Georgia
    United States
    Директор
    Peachtree Dunwoody Road
    30328 Atlanta
    6655
    Georgia
    United States
    United StatesAmericanAttorney244519610001
    BUTLER, Leonie
    The Old Chapel
    Chapel Hill
    NN14 4BG Little Addington
    Northamptonshire
    Секретарь
    The Old Chapel
    Chapel Hill
    NN14 4BG Little Addington
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director99493360003
    MCLAUGHLIN, Irene Anne
    7 Meadowbank Close
    Barnet Road
    EN5 3LY Argyle
    Hertfordshire
    Секретарь
    7 Meadowbank Close
    Barnet Road
    EN5 3LY Argyle
    Hertfordshire
    BritishAccountant147911540001
    MYER, Henry Ernest
    86 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JQ Borehamwood
    Hertfordshire
    Секретарь
    86 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JQ Borehamwood
    Hertfordshire
    British11966530001
    THRAVES, Karen
    Pine Close
    Fernwood
    NG24 3FR Newark
    18
    Nottinghamshire
    Секретарь
    Pine Close
    Fernwood
    NG24 3FR Newark
    18
    Nottinghamshire
    British132719470001
    WIJN, Johannes Jacobus Wilhelmus Henricus
    Beerseweg 35
    5443nl Haps
    Netherlands
    Секретарь
    Beerseweg 35
    5443nl Haps
    Netherlands
    DutchDirector127687420001
    WONNACOTT, Paul
    29 Lyndhurst Avenue
    KT5 9LN Surbiton
    Surrey
    Секретарь
    29 Lyndhurst Avenue
    KT5 9LN Surbiton
    Surrey
    BritishDirector13329080001
    YEMC, Peter William
    20 Wyndham Park
    Orton Wistow
    PE2 6XU Peterborough
    Cambridgeshire
    Секретарь
    20 Wyndham Park
    Orton Wistow
    PE2 6XU Peterborough
    Cambridgeshire
    British19899100001
    ABBISS, Jeremy Gordon
    46 Bunyan Close
    Pirton
    SG5 3RE Hitchin
    Hertfordshire
    Директор
    46 Bunyan Close
    Pirton
    SG5 3RE Hitchin
    Hertfordshire
    BritishOperations Director99732810001
    BENNETT, Peter
    140 Thompson Street, Apt 6a
    New York
    New York 10012
    Us
    Директор
    140 Thompson Street, Apt 6a
    New York
    New York 10012
    Us
    UsaCompany Director104681270001
    BERMAN, Robert Paul
    950 Dean Avenue
    Highland Park
    Illinois
    Usa
    Директор
    950 Dean Avenue
    Highland Park
    Illinois
    Usa
    AmericanCompany Director73166430001
    BUTLER, Leonie
    The Old Chapel
    Chapel Hill
    NN14 4BG Little Addington
    Northamptonshire
    Директор
    The Old Chapel
    Chapel Hill
    NN14 4BG Little Addington
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director99493360003
    CLARKE, Alexander Kevin
    19 West Ilsley
    RG20 7AR Newbury
    Berkshire
    Директор
    19 West Ilsley
    RG20 7AR Newbury
    Berkshire
    BritishDirector60955420001
    DE-BRUZZI, James
    4545 West Augusta Blvd
    FOREIGN Chicago Il 60651
    Usa
    Директор
    4545 West Augusta Blvd
    FOREIGN Chicago Il 60651
    Usa
    AmericanCompany Director32014480001
    DELSAUT, Philippe Patrick Andre
    Chemin De Blandonnet 10
    1214 Vernier
    C/O Newell Rubbermaid Europe Sarl
    Geneva
    Switzerland
    Директор
    Chemin De Blandonnet 10
    1214 Vernier
    C/O Newell Rubbermaid Europe Sarl
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBelgianAttorney200413270001
    FISHER, Steven
    60 Duffield Drive
    FOREIGN South Orange
    New Jersey 07079
    Usa
    Директор
    60 Duffield Drive
    FOREIGN South Orange
    New Jersey 07079
    Usa
    AmericanCompany Director88874940001
    JOHNSON, Mark Weston, Mr.
    Peachtree Dunwoody Road
    30328 Atlanta
    6655
    Georgia
    United States
    Директор
    Peachtree Dunwoody Road
    30328 Atlanta
    6655
    Georgia
    United States
    United StatesAmericanAttorney228779670001
    MARSH, Yvonne
    101 Central Park West 18b
    New York
    Usa
    Usa
    Директор
    101 Central Park West 18b
    New York
    Usa
    Usa
    AmericanCompany Director87114190001
    MCLAUGHLIN, Irene Anne
    7 Meadowbank Close
    Barnet Road
    EN5 3LY Argyle
    Hertfordshire
    Директор
    7 Meadowbank Close
    Barnet Road
    EN5 3LY Argyle
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director147911540001
    MCNEILL, Vince
    1721 Bowling Green Drive
    Lake Forest Illinois
    FOREIGN Usa
    Директор
    1721 Bowling Green Drive
    Lake Forest Illinois
    FOREIGN Usa
    CanandianCompany Director32014490002
    METZ, Dale Lynn
    c/o C/O Newell Rubbermaid Inc.
    Glenlake Parkway
    30328 Atlanta
    3
    Georgia
    Usa
    Директор
    c/o C/O Newell Rubbermaid Inc.
    Glenlake Parkway
    30328 Atlanta
    3
    Georgia
    Usa
    UsaUsaCorporate Treasurer130381340001
    MURPHY, George
    293 South Shore Lake
    Lake Forest
    Illinois 60045
    Usa
    Директор
    293 South Shore Lake
    Lake Forest
    Illinois 60045
    Usa
    AmericanManager88875000001
    MYER, Henry Ernest
    86 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JQ Borehamwood
    Hertfordshire
    Директор
    86 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JQ Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director11966530001
    PETERSON, Michael Richard
    Peachtree Dunwoody Road
    Atlanta
    6655
    Georgia
    Usa
    Директор
    Peachtree Dunwoody Road
    Atlanta
    6655
    Georgia
    Usa
    UsaAmericanAttorney168191050002
    TORKINGTON, Kenneth David
    Mill House
    Michelham Priory
    BN27 3QS Hailsham
    Sussex
    Директор
    Mill House
    Michelham Priory
    BN27 3QS Hailsham
    Sussex
    BritishSalesman38937530001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Директор
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsaCompany Director152264500001
    WIJN, Johannes Jacobus Wilhelmus Henricus
    Beerseweg 35
    5443nl Haps
    Netherlands
    Директор
    Beerseweg 35
    5443nl Haps
    Netherlands
    DutchManaging Director127687420001
    YEMC, Peter William
    24 Trienna The Village
    Orton Longueville
    PE2 7ZW Peterborough
    Cambridgeshire
    Директор
    24 Trienna The Village
    Orton Longueville
    PE2 7ZW Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director19899100002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Polyhedron Holdings Limited
    Halifax Avenue
    Fradley Park
    WS13 8SS Lichfield
    Halifax Avenue
    England
    28 июл. 2016 г.
    Halifax Avenue
    Fradley Park
    WS13 8SS Lichfield
    Halifax Avenue
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеEngland And Wales
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер01866165
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у NEWELL RUBBERMAID GLOBAL LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Legal charge
    Создан 26 февр. 2007 г.
    Поставлен 28 февр. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H the neutralle centre cully court orton southgate peterborough. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 28 февр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 апр. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 февр. 2006 г.
    Поставлен 08 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the non-us obligors to the chargee and any or all of the UK lenders and the dutch lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All that l/h land being plot 4A bakewell road peterborough. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Capitalsource Finance L.L.C. as Agent and Collateral Agent
    Транзакции
    • 08 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 апр. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 20 мая 2005 г.
    Поставлен 28 мая 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 28 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 20 мая 2005 г.
    Поставлен 28 мая 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property k/a plot 4A bakewell road peterborough. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 28 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2006 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 25 апр. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 18 мая 1998 г.
    Поставлен 01 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 01 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 12 февр. 1997 г.
    Поставлен 18 февр. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 18 февр. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0