BL HC INVIC LEISURE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBL HC INVIC LEISURE LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02464159
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Юридический адрес
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    INVICTA LEISURE LIMITED26 янв. 1990 г.26 янв. 1990 г.

    Каковы последние отчеты BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2022 г.

    Какие последние документы подавались BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Уведомление о подтверждении, составленное 23 февр. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited как лица, осуществляющего значительный контроль, 25 нояб. 2022 г.

    1 страницыPSC07

    Уведомление о Bl Retail Warehousing Holding Company Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 25 нояб. 2022 г.

    2 страницыPSC02

    Прекращение полномочий Katherine Fyfe в качестве директора 17 окт. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mrs Katherine Fyfe 20 июл. 2022 г.

    2 страницыCH01

    Назначение Mrs Katherine Fyfe на должность директора 20 июл. 2022 г.

    2 страницыAP01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    23 мая 2023 г.Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23rd May 2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Отчет о капитале на 21 апр. 2022 г.

    • Капитал: GBP 1.00
    5 страницыSH19

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Прекращение полномочий Charles John Middleton в качестве директора 31 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Gavin Bergin на должность директора 18 мар. 2022 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Sarah Morrell Barzycki в качестве директора 18 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Jonathan Charles Mcnuff в качестве директора 18 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Nick Taunt на должность директора 18 мар. 2022 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Nigel Mark Webb в качестве директора 18 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Paul Stuart Macey в качестве директора 18 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 23 февр. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 23 февр. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Кто является должностными лицами BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Секретарь компании
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Секретарь
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    BritishAccountant58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Секретарь
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162246380001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Секретарь
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    BritishAccountant58345490001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Секретарь
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Секретарь
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Секретарь
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    BritishSports Consultant50477690001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Секретарь
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Директор
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Директор
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Директор
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Директор
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    BritishChartered Accountant35128740001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Директор
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritishSolicitor125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Директор
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    EnglandBritishCompany Director3716600001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Директор
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritishCompany Director2968140002
    DAVIES, Rhian Lynn
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    Директор
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    BritishDirector48466920001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Директор
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Директор
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director13332510001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Директор
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritishDirector58345490001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAssistant Company Secretary293284010001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Директор
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    BritishDirector Of Companies45468220001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Директор
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GRIFFITHS, Paul Richard
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Директор
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    BritishInvestment Manager54611260001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Директор
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Директор
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director, Esporta G100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Директор
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector135618280002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 нояб. 2022 г.
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland
    Регистрационный номер06002154
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 апр. 2016 г.
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Да
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    • Лицо имеет право осуществлять или фактически осуществляет существенное влияние или контроль над компанией.

    Есть ли у BL HC INVIC LEISURE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Fixed and floating security document
    Создан 18 июн. 2009 г.
    Поставлен 26 июн. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Транзакции
    • 26 июн. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 июл. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Assignment of receivables
    Создан 18 июн. 2009 г.
    Поставлен 26 июн. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Right title and interest in and to the receivables see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Esporta Financial Services Limited
    Транзакции
    • 26 июн. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 июл. 2009 г.
    • 08 февр. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Group debenture
    Создан 08 февр. 2006 г.
    Поставлен 18 февр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Транзакции
    • 18 февр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 27 янв. 2004 г.
    Поставлен 07 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Транзакции
    • 07 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 27 янв. 2004 г.
    Поставлен 03 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 03 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental charge
    Создан 09 сент. 2003 г.
    Поставлен 12 сент. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 12 сент. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 05 сент. 2002 г.
    Поставлен 09 сент. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Транзакции
    • 09 сент. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deposit deed
    Создан 14 июн. 2001 г.
    Поставлен 28 июн. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein.
    Уполномоченные лица
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Транзакции
    • 28 июн. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deposit deed
    Создан 18 апр. 2000 г.
    Поставлен 26 апр. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £100,000 due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Charge over the deposit of £100,000.
    Уполномоченные лица
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Транзакции
    • 26 апр. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 окт. 1999 г.
    Поставлен 28 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Company
    Транзакции
    • 28 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 10 мар. 1999 г.
    Поставлен 24 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Транзакции
    • 24 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 08 мар. 1999 г.
    Поставлен 23 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Company
    Транзакции
    • 23 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 30 мая 1996 г.
    Поставлен 10 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Company
    Транзакции
    • 10 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 30 мая 1996 г.
    Поставлен 07 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners
    Транзакции
    • 07 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 01 июл. 1994 г.
    Поставлен 20 июл. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547.
    Уполномоченные лица
    • The Lawn Tennis Association
    Транзакции
    • 20 июл. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of amendment
    Создан 13 февр. 1992 г.
    Поставлен 20 февр. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Co.
    Транзакции
    • 20 февр. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment of life policies
    Создан 07 янв. 1992 г.
    Поставлен 15 янв. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge
    Краткое описание
    The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Co.
    Транзакции
    • 15 янв. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 16 сент. 1991 г.
    Поставлен 23 сент. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge
    Краткое описание
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Coutts & Co.
    Транзакции
    • 23 сент. 1991 г.Регистрация залога
    • 26 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0