ASPECT VENTURES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииASPECT VENTURES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02468264
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ASPECT VENTURES LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится ASPECT VENTURES LIMITED?

    Юридический адрес
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ASPECT VENTURES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 апр. 1990 г.02 апр. 1990 г.
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 апр. 1990 г.02 апр. 1990 г.
    LEGIBUS 1520 LIMITED08 февр. 1990 г.08 февр. 1990 г.

    Каковы последние отчеты ASPECT VENTURES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на29 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались ASPECT VENTURES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    11 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 15 янв. 2021 г.

    10 страницыLIQ03

    Уведомление о подтверждении, составленное 29 дек. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Юридический адрес изменен с Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom на Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU 27 янв. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 16 янв. 2020 г.

    LRESSP

    Отчет о капитале на 30 дек. 2019 г.

    • Капитал: GBP 1
    3 страницыSH19

    Уведомление о подтверждении, составленное 29 дек. 2019 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    10 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 29 дек. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Назначение Mr Richard Smothers на должность директора 31 янв. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Kirk Dyson Davis в качестве директора 31 янв. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    18 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 29 дек. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    20 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 03 янв. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    19 страницыAR01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    30 нояб. 2016 г.Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2012 as it was not properly delivered

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    22 страницыAR01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    30 нояб. 2016 г.Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2011 as it was not properly delivered

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    22 страницыAR01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    30 нояб. 2016 г.Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2010 as it was not properly delivered

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    Кто является должностными лицами ASPECT VENTURES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Секретарь
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524030001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Директор
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BRIDGE, John Nigel
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    Секретарь
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    British39560640001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Секретарь
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    British97033480001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Секретарь
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591790001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444930001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Секретарь
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Секретарь
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022150001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Секретарь
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Директор
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Директор
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish97033480001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    DYSON, Ian
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish154003250001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Colin David
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    Директор
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish1850120001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Директор
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Директор
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritish895970001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Директор
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Директор
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Директор
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Директор
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над ASPECT VENTURES LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер4872046
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у ASPECT VENTURES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Amendment and restatement deed
    Создан 07 июл. 2006 г.
    Поставлен 21 июл. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Truste Company Limited in Its Capacity as the "Issuer Security Trustee" and "Borrowergroup Security Trustee"
    Транзакции
    • 21 июл. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Supplemental deed of charge
    Создан 21 мар. 2006 г.
    Поставлен 31 мар. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Trustee Company Limited as Agent and Trustee for the Borrower Secured Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Borrower group deed of charge
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 13 дек. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Trustee for the Borrower Secured Parties)
    Транзакции
    • 13 дек. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Security agreement
    Создан 15 дек. 2003 г.
    Поставлен 31 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Ansty arms, coventry f/h t/n's WK251251 & WK251242. Bay horse, wigan f/h t/n's GM85094 & GM484585. Berkshire arms, nr newbury f/h t/n BK249470 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Транзакции
    • 31 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 09 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security agreement
    Создан 15 дек. 2003 г.
    Поставлен 31 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Транзакции
    • 31 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июн. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 07 нояб. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у ASPECT VENTURES LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    16 янв. 2020 г.Начало ликвидации
    25 апр. 2022 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Практик
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Практик
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0