NSIP (ETS) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииNSIP (ETS) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02504173
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель NSIP (ETS) LIMITED?

    • Вспомогательные виды деятельности по добыче нефти и природного газа (09100) / Добыча полезных ископаемых

    Где находится NSIP (ETS) LIMITED?

    Юридический адрес
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия NSIP (ETS) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    CH4 PIPELINES LIMITED28 июл. 2003 г.28 июл. 2003 г.
    CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED08 дек. 1997 г.08 дек. 1997 г.
    POWER TOWER LIMITED06 июл. 1990 г.06 июл. 1990 г.
    HASTESPOT LIMITED21 мая 1990 г.21 мая 1990 г.

    Каковы последние отчеты NSIP (ETS) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались NSIP (ETS) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    1 страницыDS01

    Изменение данных директора для Mr Thomas Jack Robert Luypaert 08 июн. 2020 г.

    2 страницыCH01

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 июн. 2020 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Изменение данных директора для Mr Thomas Jack Robert Luypaert 30 янв. 2020 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных о Kellas North Sea 2 Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 30 янв. 2020 г.

    2 страницыPSC05

    Изменение данных директора для Mr Andrew David Hessell 30 янв. 2020 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Guy Robert Maurice Appleton 30 янв. 2020 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom на Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB 04 февр. 2020 г.

    1 страницыAD01

    Назначение Mr Thomas Jack Robert Luypaert на должность директора 30 янв. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Guillaume Jacques Robert Friedel в качестве директора 30 янв. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Stephane Julien Ifker в качестве директора 30 янв. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Mark John Crosbie в качестве директора 30 янв. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr Guillaume Jacques Robert Friedel 01 авг. 2019 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных о Antin North Sea 2 Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 16 сент. 2019 г.

    2 страницыPSC05

    Годовая бухгалтерская отчетность

    24 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 июн. 2019 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Полное погашение обременения 025041730011

    4 страницыMR04

    Вторая подача заявления о назначении Mr Mark John Crosbie директором

    6 страницыRP04AP01

    Изменение данных директора для Mr Guillaume Jacques Robert Friedel 20 июн. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA

    Юридический адрес изменен с 14 st George Street London London W1S 1FE на 14 st. George Street London W1S 1FE 05 июл. 2018 г.

    1 страницыAD01

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 июн. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Изменение данных о Antin North Sea 2 Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 15 февр. 2018 г.

    2 страницыPSC05

    Кто является должностными лицами NSIP (ETS) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    APPLETON, Guy Robert Maurice
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Директор
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish156848840001
    HESSELL, Andrew David
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Директор
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish221140270001
    LUYPAERT, Thomas Jack Robert
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    Директор
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    United KingdomFrench264133230002
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Секретарь
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HOBDEN, Brian
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    Секретарь
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    British81368370001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Секретарь
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    MISTRY, Bhavna
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    Секретарь
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    British87625170001
    SPARKES, Michael Jack
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    Секретарь
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    British43902400001
    WAITE, Simon Nicholas
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    Секретарь
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    British117008750002
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Секретарь компании
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер4049225
    146095800001
    WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номерOC400678
    199087250001
    ABEL, Gregory Edward
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    Директор
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    UsaCanadian52806480009
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Директор
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205850001
    BRICKNELL, Bruce David Neil
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish184345640001
    CLAYTON, Marie-Louise
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    Директор
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    British103782580001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Директор
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglish72946860001
    CROSBIE, Mark John
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Директор
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish211079810001
    DAVIES, John George
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Директор
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British54724650001
    DIXON, Ronald
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    Директор
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    EnglandBritish2318270001
    FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Директор
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United StatesFrench189459340023
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Директор
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish108926390001
    GROVES, Alan
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Директор
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British2318230001
    GUGEN, Francis Robert
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    Директор
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish388450006
    HANAFIN, Vincent Mark
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Директор
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish131999620002
    IFKER, Stephane Julien
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Директор
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    FranceFrench229631470001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Директор
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Директор
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    EnglandBritish4958800007
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Директор
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritish52698930001
    LUMSDEN, Roy Andrew
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Директор
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish199053700001
    MORRIS, David Richard
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    Директор
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritish36692700001
    MURPHY, Jonathan David
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Директор
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205970001
    OZSANLAV, Richard
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Директор
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147826530002
    PICOTTE, Christopher
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    Директор
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    American116230600001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Директор
    AB15
    United KingdomBritish124423900001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Директор
    AB15
    United KingdomBritish124423900001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над NSIP (ETS) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    21 дек. 2017 г.
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер10778448
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Да
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер3186121
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у NSIP (ETS) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 26 мар. 2018 г.
    Поставлен 26 мар. 2018 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    N/A.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Rbc Europe Limited
    Транзакции
    • 26 мар. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 24 янв. 2007 г.
    Поставлен 31 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Транзакции
    • 31 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Bond and floating charge
    Создан 22 янв. 2007 г.
    Поставлен 31 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Транзакции
    • 31 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 21 июл. 2006 г.
    Поставлен 28 июл. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 28 июл. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 сент. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and
    Создан 27 янв. 2006 г.
    Поставлен 09 февр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Транзакции
    • 09 февр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and
    Создан 27 янв. 2006 г.
    Поставлен 09 февр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Транзакции
    • 09 февр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005
    Создан 23 дек. 2005 г.
    Поставлен 10 янв. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Транзакции
    • 10 янв. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 23 дек. 2003 г.
    Поставлен 13 янв. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Bank Ag
    Транзакции
    • 13 янв. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 авг. 2003 г.
    Поставлен 04 сент. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • 3I Group PLC
    Транзакции
    • 04 сент. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 мая 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 01 июл. 1999 г.
    Поставлен 14 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 14 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 апр. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 05 июн. 1998 г.
    Поставлен 22 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 22 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 апр. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0