BELLA REALISATIONS 1 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBELLA REALISATIONS 1 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02521829
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    • Деятельность прочих холдинговых компаний, не включенных в другие группировки (64209) / Финансовая и страховая деятельность

    Где находится BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Юридический адрес
    Ship Canal House, 8th Floor, 98
    King Street
    M2 4WU Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BELLA ITALIA GROUP LIMITED16 мая 2006 г.16 мая 2006 г.
    BRIGHTREASONS GROUP LIMITED25 апр. 1994 г.25 апр. 1994 г.
    BRIGHTREASONS LIMITED14 янв. 1991 г.14 янв. 1991 г.
    BRIGHTREASON LIMITED13 июл. 1990 г.13 июл. 1990 г.

    Каковы последние отчеты BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на26 мая 2019 г.

    Какие последние документы подавались BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Уведомление о переходе от администрации к роспуску

    40 страницыAM23

    Юридический адрес изменен с 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB на Ship Canal House, 8th Floor, 98 King Street Manchester M2 4WU 29 мар. 2021 г.

    2 страницыAD01

    Отчет о ходе администрации

    66 страницыAM10

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 025218290016

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 025218290017

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 025218290019

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 025218290018

    11 страницыMR05

    Прекращение полномочий James Forrester Spragg в качестве директора 08 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Adrian Rowland Walker в качестве директора 08 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed bella italia group LIMITED\certificate issued on 15/10/20
    3 страницыCERTNM
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA

    9 страницыAM02

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    5 страницыAM06

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Юридический адрес изменен с 1st Floor 163 Eversholt Street London NW1 1BU на 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB 15 июл. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    5 страницыAM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 мая 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    2 страницыAA

    Назначение Mr Adrian Walker на должность директора 06 дек. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Регистрация обременения 025218290019, создано 14 янв. 2020 г.

    24 страницыMR01

    Прекращение полномочий Giles Matthew Oliver David в качестве секретаря 06 дек. 2019 г.

    1 страницыTM02

    Прекращение полномочий Giles Matthew Oliver David в качестве директора 06 дек. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 мая 2019 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Назначение Mr James Forrester Spragg на должность директора 30 апр. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BAKER, Ian Stewart
    45 Ashburnham Place
    Greenwich
    SE10 8UG London
    Секретарь
    45 Ashburnham Place
    Greenwich
    SE10 8UG London
    British67628330001
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    Секретарь
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    British39442340002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Секретарь
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    237559820001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Секретарь
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    BritishCommercial Lawyer31440290005
    FRANKLIN, Robert Norman Carew
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    Секретарь
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    British37258120002
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Секретарь
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    BritishCompany Director64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Секретарь
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    BritishDirector49107830002
    SIMS, Robin Edward
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    Секретарь
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    British52343580001
    ARMITAGE, Ian
    18 Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BU Richmond
    Surrey
    Директор
    18 Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BU Richmond
    Surrey
    BritishFund Manager19597270001
    ARMITAGE, Ian
    18 Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BU Richmond
    Surrey
    Директор
    18 Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BU Richmond
    Surrey
    BritishFund Manager19597270001
    ASPEL, Edward
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    Директор
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector62933370001
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Директор
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director67628330002
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Директор
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishDirector67628330002
    BARBOUR, Niel Paterson
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    Директор
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    BritishGroup Operation Director71423490001
    BULLOCK, John
    Braddocks
    Oak Avenue
    TN13 1PR Sevenoaks
    Kent
    Директор
    Braddocks
    Oak Avenue
    TN13 1PR Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant27610060002
    CLEWLEY, Robert Richard
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    Директор
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    United KingdomBritishExecutive85729830001
    CUSHING, Philip Edward
    Warren End
    Warren Cutting
    KT2 7HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Директор
    Warren End
    Warren Cutting
    KT2 7HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishGeneral Manager69325760003
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishAccountant187907210001
    DAVIS, Samantha Clare
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    Директор
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector125626320001
    DERKACH, John
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    United KingdomBritishCeo113885080002
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Директор
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    EVANS, John Stephen David
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    Директор
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCaterer92401670001
    GREEN, Christopher David
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    Директор
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    EnglandEnglishMarketing Director100789790001
    GUTHRIE, Garth Michael
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector51714120001
    HEATH, Roger Anthony Frederick
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    Директор
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    BritishCompany Director5640920001
    HEATH, Roger Anthony Frederick
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    Директор
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    BritishCompany Director5640920001
    HENFREY, Anthony William, Dr
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    Директор
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    EnglandBritishCompany Director42207200001
    JOHNSON, Michael Andrew
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    Директор
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director98243170001
    JOHNSON, Rowland Christopher
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    Директор
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    BritishDirector71910140001
    LANE, Graham
    Elysium Chapel Lane
    Naphill
    HP14 4RB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Директор
    Elysium Chapel Lane
    Naphill
    HP14 4RB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director58965040003
    LAWRENCE, Kenneth William
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    Директор
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Banker40388380001
    LESTER, Jeremy William
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    Директор
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    BritishAccountant50628960002
    LONG, Jeremy Paul Warwick
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    Директор
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    BritishDirector7764450001
    LUDBROOK, Michael Sydney
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Директор
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    BritishDirector60035400001
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishCompany Director64318140002

    Каковы последние заявления о лицах, осуществляющих значительный контроль над BELLA REALISATIONS 1 LIMITED?

    Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
    УведомленПрекращеноЗаявление
    31 мая 2017 г.Компания еще не завершила разумные шаги для выяснения, является ли кто-либо регистрируемым лицом или регистрируемым соответствующим юридическим лицом в отношении компании.

    Есть ли у BELLA REALISATIONS 1 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 14 янв. 2020 г.
    Поставлен 16 янв. 2020 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Транзакции
    • 16 янв. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 15 авг. 2018 г.
    Поставлен 24 авг. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01. For more details please refer to the supplemental debenture.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 24 авг. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 15 авг. 2018 г.
    Поставлен 23 авг. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    None at the date of the charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 23 авг. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 05 февр. 2016 г.
    Поставлен 09 февр. 2016 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 09 февр. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 20 июл. 2015 г.
    Поставлен 07 авг. 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    "Pizza pizza" trademark, registration number 42067. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 07 авг. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 19 февр. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 12 мая 2015 г.
    Поставлен 15 мая 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    UK trademarks bella pasta and bella pasta (stylised) 2030480 and 1474369 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S.Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Транзакции
    • 15 мая 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 19 февр. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 30 сент. 2014 г.
    Поставлен 03 окт. 2014 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 03 окт. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating security document
    Создан 25 июл. 2007 г.
    Поставлен 31 июл. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All its right, title and interest in and to the assigned contracts all insurances and a fixed charge on all present and future real property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 июл. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating security document
    Создан 22 янв. 2007 г.
    Поставлен 26 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All right title and interest in and to the assigned contracts, all insurances and a fixed charge present and future real property and other assets. Floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Транзакции
    • 26 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 25 мая 2006 г.
    Поставлен 09 июн. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All property,first fixed charge all other property,all licences,all computers,vehicles,office equipment and other equipment,the benefit of all contracts,licences and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC the "Security Agent"
    Транзакции
    • 09 июн. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession and amendment
    Создан 28 апр. 2005 г.
    Поставлен 10 мая 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    A grant of security over all security interests and disposistions and are created with a full title guarantee and are continuing security for payment of all of the secured obligations. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC ( the Security Agent)
    Транзакции
    • 10 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 17 янв. 2005 г.
    Поставлен 29 янв. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 29 янв. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 31 мая 2002 г.
    Поставлен 11 июн. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    20A winchester street basingstoke; unit 1 bishops wharf 39 and 49 parkgate road; 296/298 high street berkhamsted t/nos: HP536633 TGL104043 HD351012. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 11 июн. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 февр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 12 окт. 1995 г.
    Поставлен 19 окт. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture and loan agreement of even date
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Mercury Asset Management PLC
    Транзакции
    • 19 окт. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Second supplemental guarantee and debenture
    Создан 28 февр. 1994 г.
    Поставлен 21 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to samuel montagu & co. Limited (the agent),the arranger,the banks (or any of them) and/or the overdreft bank under each of the financing documents (as defined) to which such obligor is a party
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co.
    Транзакции
    • 21 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mezzanine guarantee and debenture
    Создан 18 февр. 1993 г.
    Поставлен 10 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the agent, as agent and trustee for itself and each lender (as defined) under the terms of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    (See form 395 and attached schedules for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Транзакции
    • 10 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Создан 18 февр. 1993 г.
    Поставлен 10 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the agent, as agent and trustee for itself, the arranger, the overdraft bank and each bank (as defined) under the terms of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    By way of first legal mortgage all the property (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Транзакции
    • 10 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 18 февр. 1993 г.
    Поставлен 04 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from pizzaland international to the chargee under or pursuant to clause 3.5 (c) and clause 15.1 of a sale agreement dated 18TH february 1993 and this debenture
    Краткое описание
    See form 395 M8 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Rank Restaurants Holdings Limited
    Транзакции
    • 04 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 февр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 20 февр. 1991 г.
    Поставлен 04 мар. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obigations of each obligorts samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself, the arranger and the banks (or any of t hem) and/or the overdraft bank under each of the financing documents (as define d) to which each obligor is a party.
    Краткое описание
    (Please see form 395 and continuation sheets for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Транзакции
    • 04 мар. 1991 г.Регистрация залога
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у BELLA REALISATIONS 1 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    08 июл. 2021 г.Окончание управления
    02 июл. 2020 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Практик
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Daniel Imison
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0