THE NICE PUB COMPANY LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTHE NICE PUB COMPANY LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02588139
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Юридический адрес
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на29 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    11 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 15 янв. 2021 г.

    10 страницыLIQ03

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Юридический адрес изменен с Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom на Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU 30 янв. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 16 янв. 2020 г.

    LRESSP

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 мар. 2019 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    10 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 мар. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Прекращение полномочий Kirk Dyson Davis в качестве директора 31 янв. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Richard Smothers на должность директора 31 янв. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    9 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 мар. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    11 страницыAA

    Назначение Lindsay Anne Keswick на должность секретаря 25 апр. 2016 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Claire Susan Stewart в качестве секретаря 25 апр. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ на Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT 07 мар. 2016 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital07 мар. 2016 г.

    Отчет о капитале на 07 мар. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Прекращение полномочий Jonathan Robert Langford в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Daryl Antony Kelly в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Lucy Jane Bell в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Kirk Dyson Davis на должность директора 21 дек. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Henry Jones в качестве секретаря 04 дек. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Кто является должностными лицами THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Секретарь
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524230001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Директор
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector242658700001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Секретарь
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector67008750001
    HALDENBY, Martin Jonathan
    67 Wilson Street
    HU10 7AJ Anlaby
    East Yorkshire
    Секретарь
    67 Wilson Street
    HU10 7AJ Anlaby
    East Yorkshire
    British33479480001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592300001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    LUNT, Simon William
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    Секретарь
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    British35566230001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    8 Stratton Park
    Swanland
    HU14 3NN North Ferriby
    North Humberside
    Секретарь
    8 Stratton Park
    Swanland
    HU14 3NN North Ferriby
    North Humberside
    BritishCompany Director24300100001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    Секретарь
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    British24300100006
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445180001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Секретарь
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021610001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Секретарь
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Секретарь
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Секретарь
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Директор
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretariat Executive42996540002
    DUFFILL, Clare Marianne
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    Директор
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    BritishCompany Secretariat Assisant71005690002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Директор
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishDirector47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    LUNT, Simon William
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    Директор
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    BritishSolicitor35566230001
    MAPP, Derek
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    Директор
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector-Retail12473610001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Директор
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCQUARTER, Mark
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishManaging Director57915140001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер2673413
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у THE NICE PUB COMPANY LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Guarantee and debenture
    Создан 03 сент. 2000 г.
    Поставлен 15 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H l/h property k/a peacock inn 714 stannington nr sheffield t/no syk 344618 and SYK356684 ark tavern chesterfield road brimington chesterfield derbyshire t/no DY253380 and DY270253 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Транзакции
    • 15 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 мар. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 06 янв. 1995 г.
    Поставлен 14 янв. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a guarantee and debenture dated 10/3/94
    Краткое описание
    F/H land k/a the travellers rest public house intake lane pogmoor t/no SYK349003.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 14 янв. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 10 мар. 1994 г.
    Поставлен 14 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and/or the swap agreements (as defined therein)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Lenders and the Swap Counterparties (As Defined Therein)
    Транзакции
    • 14 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 10 мар. 1994 г.
    Поставлен 14 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys standing to the credit of the accounts of the companies as per form 395.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 14 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 авг. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 21 апр. 1993 г.
    Поставлен 24 апр. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys standing to the credit of the account or accounts of the company by way of fixed and specific charge.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 24 апр. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 06 мая 1992 г.
    Поставлен 22 мая 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or any of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 22 мая 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 06 мая 1992 г.
    Поставлен 19 мая 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee under the terms of the facility agreement and/or any of the financing documents (as defined) or pursuant to tthe trading agreement
    Краткое описание
    See form 395 and continuation sheets relevant to this charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Scottish & Newcastle PLC or Any Other Member of the Scottish & Newcastle PLC Group of Companies
    Транзакции
    • 19 мая 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 апр. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у THE NICE PUB COMPANY LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    16 янв. 2020 г.Начало ликвидации
    25 апр. 2022 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Практик
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Практик
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0