OLDNAME NO. 397 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииOLDNAME NO. 397 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02589210
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    • (3002) /

    Где находится OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Юридический адрес
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    DIAGNOSYS LIMITED11 июн. 1991 г.11 июн. 1991 г.
    D.C.A.-I.L. SYSTEMS LIMITED20 мая 1991 г.20 мая 1991 г.
    LETTERDETAIL LIMITED07 мар. 1991 г.07 мар. 1991 г.

    Каковы последние отчеты OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2007 г.

    Какие последние документы подавались OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    20 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 28 янв. 2019 г.

    19 страницыLIQ03

    Назначение ликвидатора

    4 страницы600

    Юридический адрес изменен с 10 Furnival Street London EC4A 1YH на 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU 08 мар. 2018 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    страницы2.34B

    Восстановление по решению суда

    2 страницыAC92

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    3 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 06 апр. 2012 г.

    10 страницы4.68

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Уведомление о прекращении деятельности в качестве добровольного ликвидатора

    1 страницы4.40

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 06 апр. 2011 г.

    13 страницы4.68

    Юридический адрес изменен с * 66 Wigmore Street London W1A 3RT* 04 мар. 2011 г.

    2 страницыAD01

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    9 страницы2.34B

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    7 страницы2.34B

    Отчет о ходе администрации до 12 нояб. 2009 г.

    6 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 12 нояб. 2009 г.

    6 страницы2.24B

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    15 страницы2.16B

    Заявление о предложениях администратора

    30 страницы2.17B

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed diagnosys LIMITED\certificate issued on 26/06/09
    2 страницыCERTNM

    legacy

    1 страницы287

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    legacy

    1 страницы288c

    Кто является должностными лицами OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GOULIMIS, Denise
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Директор
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Greek133964450001
    HARRISON, John Trevor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    Директор
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish120531710001
    HEASMAN, Philip
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    Директор
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    United KingdomAustralian63852560002
    MCINTOSH, Charles William Allistair
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    Директор
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    British133364010001
    MCINTOSH, Ian Alexander Neville
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    Директор
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    United KingdomBritish60901880002
    SMITH, Robert Louis
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    British131286830001
    WOODING, Jeremy Michael
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    Директор
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    EnglandBritish54883990002
    CHANT, John
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    Секретарь
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    British34373580001
    WAKE, Nicholas
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    Секретарь
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    British42620390002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Номинированный секретарь
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNARD, Adam
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    Директор
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    South African65525620002
    BRIDLE, Mark Leslie
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    Директор
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    British8862860001
    CAWKELL, David
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    Директор
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    EnglandBritish29634190002
    LOCK, Maureen
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    Директор
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    South African78409990001
    TIPLIN, David Robert
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    Директор
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    EnglandBritish82007290001
    WAKE, Nicholas
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    Директор
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    British42620390003
    WELLAND, Paul Stephen
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    Директор
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    British13174060002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Номинированный директор
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Есть ли у OLDNAME NO. 397 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 22 авг. 2008 г.
    Поставлен 28 авг. 2008 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 28 авг. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 06 нояб. 2003 г.
    Поставлен 15 нояб. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 15 нояб. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 сент. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 25 окт. 2002 г.
    Поставлен 08 нояб. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold properties units 2 and 3 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire. Unit 15 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire and unit 4 viceroy court, bedford road, petersfield, hampshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Транзакции
    • 08 нояб. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    Instrument creating secured loan stock 2005 of the company
    Создан 25 окт. 2002 г.
    Поставлен 08 нояб. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    By way of continuing security in favour of the stockholder for the payment and discharge of secured loabn stock 2005 constituted by the secured loan stock instrument with a principal amount of £1,000,000 plus interest and costs
    Краткое описание
    By way of a fixed charge all estate or interest in any freehold and leasehold property and any proceeds of sale now and in the future vested in the company. By way of a fixed charge all its right, title, interest and benefit present and future in and to the plant, machinery and fixtures and fittings at the property, the furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the goodwill and uncalled capital, the book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Транзакции
    • 08 нояб. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    Legal mortgage
    Создан 30 июн. 1999 г.
    Поставлен 09 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property k/a plot e vision park petersfield hants. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 нояб. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 29 янв. 1996 г.
    Поставлен 05 февр. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 05 февр. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 окт. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у OLDNAME NO. 397 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    13 мая 2009 г.Начало управления
    07 апр. 2010 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Практик
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Практик
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    2
    ДатаТип
    07 апр. 2010 г.Начало ликвидации
    17 окт. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Практик
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Практик
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Практик
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Практик
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0