QYJ (ESSEX) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииQYJ (ESSEX) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02600901
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель QYJ (ESSEX) LIMITED?

    • Грузовые автоперевозки (49410) / Транспорт и хранение

    Где находится QYJ (ESSEX) LIMITED?

    Юридический адрес
    Unit 291 & 296 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия QYJ (ESSEX) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    NIGHTFREIGHT (ESSEX) LIMITED17 мая 1991 г.17 мая 1991 г.
    ALPHAGATE LIMITED12 апр. 1991 г.12 апр. 1991 г.

    Каковы последние отчеты QYJ (ESSEX) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 нояб. 2010 г.

    Какие последние документы подавались QYJ (ESSEX) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницы4.71

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 09 нояб. 2012 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital01 мая 2012 г.

    Отчет о капитале на 01 мая 2012 г.

    • Капитал: GBP 97,500
    SH01

    Прекращение полномочий Peter Louden в качестве директора 13 мар. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Юридический адрес изменен с Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB 11 апр. 2012 г.

    1 страницыAD01

    Изменение данных директора для Mr Peter Louden 07 дек. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Изменение данных директора для Mr Peter Louden 26 нояб. 2010 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Прекращение полномочий Bernard Burns в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Peter Louden на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Изменение данных секретаря для Ian David Horsfall 12 апр. 2010 г.

    1 страницыCH03

    Бухгалтерская отчетность

    5 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    Бухгалтерская отчетность

    5 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Бухгалтерская отчетность

    5 страницыAA

    Кто является должностными лицами QYJ (ESSEX) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Секретарь
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    BritishFinance Director104565220001
    HORSFALL, Ian David
    35 Long Street
    Bulkington
    CV12 9JZ Bedworth
    Warwickshire
    Директор
    35 Long Street
    Bulkington
    CV12 9JZ Bedworth
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director104565220001
    CARRIGAN, Anthony William
    22a St Marys Avenue
    CM12 9DU Billericay
    Essex
    Секретарь
    22a St Marys Avenue
    CM12 9DU Billericay
    Essex
    BritishCompany Secretary34585010001
    GWILLIAM, Stephen Paul
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    Секретарь
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    British93396970001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Секретарь
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    WEBSTER, Jason James
    30 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    Секретарь
    30 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    British51443500001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Номинированный секретарь
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BLACK, David Russell
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Директор
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director2755270005
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    Директор
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector239557120001
    GORMLEY, George
    18 Gloucester Road
    GL20 5SY Tewkesbury
    Gloucestershire
    Директор
    18 Gloucester Road
    GL20 5SY Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant42452240001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Директор
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelshDirector161123860001
    LOUDEN, Peter
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Директор
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector172376370001
    POTTER, Ian Roger
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    Директор
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant63766210003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Директор
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Директор
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    WEBSTER, Irene
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    Директор
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    BritishDirector84733860001
    WEBSTER, Isobel
    5 Chepstow Drive
    Windwood
    ST17 4TT Stafford
    Staffordshire
    Директор
    5 Chepstow Drive
    Windwood
    ST17 4TT Stafford
    Staffordshire
    BritishDirector40660620001
    WEBSTER, James
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    Директор
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    BritishDirector84733770001
    WEBSTER, Jason James
    30 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    Директор
    30 Mascalls Lane
    CM14 5LR Brentwood
    Essex
    BritishDirector51443500001
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Номинированный директор
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Есть ли у QYJ (ESSEX) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between nightfreight (essex) limited and the governor and company of the bank of scotland
    Создан 19 дек. 2001 г.
    Поставлен 02 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Краткое описание
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 июл. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between nightfreight (essex) limited and the governor and company of the bank of scotland
    Создан 19 дек. 2001 г.
    Поставлен 02 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Краткое описание
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 июл. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 20 июн. 2001 г.
    Поставлен 03 июл. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 03 июл. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 июл. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 05 мар. 2001 г.
    Поставлен 13 мар. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 13 мар. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 июл. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deposit deed
    Создан 24 мар. 1994 г.
    Поставлен 31 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The sum of £12,500 paid by the tenant to the landlord.
    Уполномоченные лица
    • Nokia Unterhaltungselektronil Gmbh
    Транзакции
    • 31 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 25 мар. 1993 г.
    Поставлен 07 апр. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 25/03/93
    Краткое описание
    £12,500.
    Уполномоченные лица
    • Nokia Unterhaltungselektronik Gmbh
    Транзакции
    • 07 апр. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A credit agreement
    Создан 08 янв. 1993 г.
    Поставлен 15 янв. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £19780.50 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Краткое описание
    All right title and interest in and to all sums payable under the agreement.
    Уполномоченные лица
    • Close Brothers Limited
    Транзакции
    • 15 янв. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 мар. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 19 июн. 1991 г.
    Поставлен 21 июн. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 июн. 1991 г.Регистрация залога
    • 21 июн. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у QYJ (ESSEX) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    09 нояб. 2012 г.Начало ликвидации
    06 мая 2013 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0