WALTERS OEP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииWALTERS OEP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02608711
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель WALTERS OEP LIMITED?

    • (3162) /

    Где находится WALTERS OEP LIMITED?

    Юридический адрес
    Unit B Knaves Beech Business Park
    Davies Way
    HP10 9FF High Wycombe
    Buckinghamshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия WALTERS OEP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED23 июл. 1991 г.23 июл. 1991 г.
    LYNCHETTE LIMITED08 мая 1991 г.08 мая 1991 г.

    Каковы последние отчеты WALTERS OEP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2008 г.

    Какие последние документы подавались WALTERS OEP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    1 страницыDS01

    Прекращение полномочий David Thomas Green в качестве директора 19 янв. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Ray George Atkinson в качестве директора 19 янв. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 5

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 7

    1 страницыMR04

    Юридический адрес изменен с 30 Finsbury Square London EC2P 2YU на Unit B Knaves Beech Business Park Davies Way High Wycombe Buckinghamshire HP10 9FF 06 янв. 2022 г.

    2 страницыAD01

    Восстановление по решению суда

    3 страницыAC92

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Уведомление о завершении администрации

    12 страницы2.32B

    Отчет о ходе администрации до 21 июл. 2010 г.

    17 страницы2.24B

    Заявление о предложениях администратора

    38 страницы2.17B

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    8 страницы2.16B

    Юридический адрес изменен с * Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER* 02 февр. 2010 г.

    1 страницыAD01

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    legacy

    4 страницы363a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    1 страницы288b

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    legacy

    5 страницы363a

    legacy

    2 страницы288a

    Кто является должностными лицами WALTERS OEP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    NEWELL, Mark John
    Hampden Farm
    Greenlands Lane
    HP16 9QX Great Missenden
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Hampden Farm
    Greenlands Lane
    HP16 9QX Great Missenden
    Buckinghamshire
    British52202960003
    NEWELL, Mark John
    Hampden Farm
    Greenlands Lane
    HP16 9QX Great Missenden
    Buckinghamshire
    Директор
    Hampden Farm
    Greenlands Lane
    HP16 9QX Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGeneral Manager52202960003
    WALTERS, Christopher John
    Woodlands 33 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Директор
    Woodlands 33 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DL High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishPurchasing Manager52205900003
    WALTERS, John Alfred
    Ash Lea Windmill Lane
    Widmer End
    HP15 6AT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Директор
    Ash Lea Windmill Lane
    Widmer End
    HP15 6AT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishElectro Mechanical Engineer5294610001
    HALLETT, Brian Gordon
    17 Stone Close
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    Секретарь
    17 Stone Close
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director3082920001
    MCCOLLUM, Angela Jean
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Номинированный секретарь
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900006750001
    ASHLEY TAYLOR, Martyn Paul
    West Kent House
    Croft Road
    TN6 1DL Crowborough
    East Essex
    Номинированный директор
    West Kent House
    Croft Road
    TN6 1DL Crowborough
    East Essex
    British900002220001
    ATKINSON, Ray George
    6 Harding House 24 Goucester Street
    Pimlico
    SW1V 2DN London
    Директор
    6 Harding House 24 Goucester Street
    Pimlico
    SW1V 2DN London
    BritishSales Director124362400001
    ATKINSON, Raymond
    2 The Spinney
    Hillcourt Road
    GL52 3JX Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    2 The Spinney
    Hillcourt Road
    GL52 3JX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director50919510001
    CHAMBERS, Jeffrey
    Middle Cottage
    School Lane Middleton Stoney
    OX25 4AW Bicester
    Oxfordshire
    Директор
    Middle Cottage
    School Lane Middleton Stoney
    OX25 4AW Bicester
    Oxfordshire
    BritishOperations Director124362350001
    CHAMBERS, Jeffrey
    Middle Cottage
    School Lane Middleton Stoney
    OX25 4AW Bicester
    Oxfordshire
    Директор
    Middle Cottage
    School Lane Middleton Stoney
    OX25 4AW Bicester
    Oxfordshire
    BritishSales Director124362350001
    DRY, Nicholas
    7 Shannon Road
    OX6 8RH Bicester
    Oxfordshire
    Директор
    7 Shannon Road
    OX6 8RH Bicester
    Oxfordshire
    BritishProduction Dir60606120001
    DUNNING, Ramsay John Paul
    Namaste
    High Street
    OX15 5NF Hook Norton
    Oxfordshire
    Директор
    Namaste
    High Street
    OX15 5NF Hook Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant76333400001
    GREEN, David Thomas
    Orchard End Gibraltar
    Dinton
    HP17 8TY Aylesbury
    Bucks
    Директор
    Orchard End Gibraltar
    Dinton
    HP17 8TY Aylesbury
    Bucks
    BritishDirector4219190001
    HALLETT, Adam
    63 Leach Road
    OX10 7QG Berinsfield
    Oxfordshire
    Директор
    63 Leach Road
    OX10 7QG Berinsfield
    Oxfordshire
    BritishBuyer63766400002
    HALLETT, Brian Gordon
    17 Stone Close
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    17 Stone Close
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector3082920001
    HALLETT, Gordon Philip
    57 Bushy Close
    Fogwell Road Botley
    OX2 9SJ Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    57 Bushy Close
    Fogwell Road Botley
    OX2 9SJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director119411080001
    HALLETT, Philip Roy
    9 Stone Close
    Botley
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    9 Stone Close
    Botley
    OX2 9SQ Oxford
    Oxfordshire
    BritishProduction Manager3082930001
    O'GALLAGHER, Gabrielle
    36 Manor Road
    NN13 6AJ Brackley
    Northamptonshire
    Директор
    36 Manor Road
    NN13 6AJ Brackley
    Northamptonshire
    BritishCompany Director50920340001
    PAYNE, Stanley
    9 Castle Street
    OX13 6SR Steventon
    Oxfordshire
    Директор
    9 Castle Street
    OX13 6SR Steventon
    Oxfordshire
    BritishCompany Director50919440001
    PEACHEY, Gabriellw
    9 Falcon Way
    NN13 6PZ Brackley
    Northamptonshire
    Директор
    9 Falcon Way
    NN13 6PZ Brackley
    Northamptonshire
    BritishFinance Director124362280001
    STYLE, Rodney Hill
    The Knowle Farmhouse
    Shutford Road North Newington
    OX15 6AN Banbury
    Oxfordshire
    Директор
    The Knowle Farmhouse
    Shutford Road North Newington
    OX15 6AN Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant11754520003
    YOUNG, Gabrielle
    11 Bridge Street
    NN13 7ER Brackley
    Northamptonshire
    Директор
    11 Bridge Street
    NN13 7ER Brackley
    Northamptonshire
    BritishDirector71686270003

    Есть ли у WALTERS OEP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 03 нояб. 2006 г.
    Поставлен 14 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 14 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 янв. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    All assets debenture
    Создан 24 окт. 2000 г.
    Поставлен 25 окт. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any financing agreement (as defined therein)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ge Capital Commercial Finance Limited "the Security Holder"
    Транзакции
    • 25 окт. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 янв. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    All assets debenture
    Создан 26 сент. 2000 г.
    Поставлен 07 окт. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Транзакции
    • 07 окт. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 янв. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating charge
    Создан 24 февр. 1999 г.
    Поставлен 26 февр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Краткое описание
    Fixed charge all debts and their related rights (as both terms are defined in the agreement).floating charge all the undertaking and all the property rights and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the company's stock in trade and its uncalled capital but excluding the specified debts.
    Уполномоченные лица
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 26 февр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 25 сент. 1998 г.
    Поставлен 02 окт. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of fixed charge all debts and their related rights (as both terms are defined in the agreement) purchased or to be purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason (specified debts) by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the companys stock in trade and its uncalled capital but excluding the specified debts.
    Уполномоченные лица
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 02 окт. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 17 июл. 1998 г.
    Поставлен 24 июл. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 24 июл. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit agreement
    Создан 12 июн. 1996 г.
    Поставлен 13 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £3,600 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Краткое описание
    The sum of £3,600 together with any interest and other monies added thereto.
    Уполномоченные лица
    • London & Leeds Estates Limited
    Транзакции
    • 13 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у WALTERS OEP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    14 янв. 2011 г.Окончание управления
    22 янв. 2010 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Практик
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Практик
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0