EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииEWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02649675
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Юридический адрес
    c/o TEACHER STERN LLP
    31-41 Bedford Row
    WC1R 4JH London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    KINGSHOLME LIMITED27 сент. 1991 г.27 сент. 1991 г.

    Каковы последние отчеты EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2015 г.

    Какие последние документы подавались EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Nicholas Emlyn Peter Reid в качестве директора 30 мар. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 27 сент. 2016 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Прекращение полномочий Edmund Charles Mccann в качестве директора 28 сент. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Francis Edward Boyd в качестве директора 28 сент. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital29 окт. 2015 г.

    Отчет о капитале на 29 окт. 2015 г.

    • Капитал: GBP 600
    SH01

    Прекращение полномочий Brian Snoddon в качестве директора 10 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Samuel James Harris в качестве директора 10 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    10 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    9 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital29 сент. 2014 г.

    Отчет о капитале на 29 сент. 2014 г.

    • Капитал: GBP 600
    SH01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    10 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    9 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital10 окт. 2013 г.

    Отчет о капитале на 10 окт. 2013 г.

    • Капитал: GBP 600
    SH01

    Процедура принудительной ликвидации прекращена

    1 страницыDISS40

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    9 страницыAA

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    9 страницыAR01

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    9 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    9 страницыAR01

    Юридический адрес изменен с * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* 17 нояб. 2010 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерская отчетность для малого предприятия

    8 страницыAA

    legacy

    7 страницыMG01

    Кто является должностными лицами EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Секретарь
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    British83528100001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Директор
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritish83528100001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Секретарь
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Irish113651250001
    PATTISON, Eric
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    Секретарь
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    British64178730001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Секретарь
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BOYD, Francis Edward
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Директор
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish83528370002
    BYRNE, Philip Patrick
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Директор
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Irish58604950001
    ELLIOTT, Acheson
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Директор
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Northern IrelandBritish144365710001
    HARRIS, Samuel James
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Директор
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish158466790001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Директор
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    IrelandIrish113651250001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Директор
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCANN, Edmund Charles
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Директор
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish144512890001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Директор
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOLAN, Geraldine
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Директор
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Irish83257760001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Директор
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Northern IrelandBritish75236310001
    SMYTH, Noel Martin
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Директор
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish91238420001
    SNODDON, Brian
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Директор
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish143738840001
    SNODDON, James Myrvan
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Директор
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    British143651570001
    STOUTZKER, Ian Isaac
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    Директор
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    EnglandBritish2658490001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Brunswick (No 1) Limited
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    06 апр. 2016 г.
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Страна регистрацииNorthern Ireland
    Юридическое основаниеCompanies Act Ni
    Место регистрацииUk
    Регистрационный номерNi429823
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Charge over deposits
    Создан 08 окт. 2010 г.
    Поставлен 16 окт. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Aib Group (UK) PLC (the Bank)
    Транзакции
    • 16 окт. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Security interest agreement
    Создан 17 нояб. 2005 г.
    Поставлен 30 нояб. 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Транзакции
    • 30 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    Charge over deposits
    Создан 18 окт. 2005 г.
    Поставлен 27 окт. 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Aib Group UK PLC
    Транзакции
    • 27 окт. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    Mortgage debenture
    Создан 30 июн. 2004 г.
    Поставлен 08 июл. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Aib Group (UK) PLC
    Транзакции
    • 08 июл. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 12 мар. 2004 г.
    Поставлен 25 мар. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 мар. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 03 нояб. 2000 г.
    Поставлен 13 нояб. 2000 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement)
    Краткое описание
    Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Dunloe Ewart Finance B.V.
    Транзакции
    • 13 нояб. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 14 апр. 2000 г.
    Поставлен 27 апр. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture
    Краткое описание
    Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 27 апр. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 дек. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of legal charge
    Создан 17 сент. 1992 г.
    Поставлен 02 окт. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Краткое описание
    The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Уполномоченные лица
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Транзакции
    • 02 окт. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 апр. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0