TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTOM COBLEIGH (INNS) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02684842
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Юридический адрес
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на22 авг. 2015 г.

    Какие последние документы подавались TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    10 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 янв. 2018 г.

    9 страницыLIQ03

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 февр. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Юридический адрес изменен с Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL на Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU 12 сент. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Юридический адрес изменен с Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom на 48 Warwick Street London W1B 5NL 09 февр. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 февр. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 12 янв. 2017 г.

    LRESSP

    Назначение Lindsay Anne Keswick на должность секретаря 25 апр. 2016 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Claire Susan Stewart в качестве секретаря 25 апр. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ на Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT 07 мар. 2016 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital17 февр. 2016 г.

    Отчет о капитале на 17 февр. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Прекращение полномочий Lucy Jane Bell в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Jonathan Robert Langford в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Daryl Antony Kelly в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Kirk Dyson Davis на должность директора 21 дек. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Henry Jones в качестве секретаря 04 дек. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Patrick James Gallagher в качестве директора 23 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital09 февр. 2015 г.

    Отчет о капитале на 09 февр. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital07 февр. 2014 г.

    Отчет о капитале на 07 февр. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Кто является должностными лицами TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Секретарь
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207524200001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Секретарь
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    British67008750001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592780001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    Секретарь
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    British24300100006
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445250001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Секретарь
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021510001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Секретарь
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Секретарь
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Секретарь
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Директор
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British42996540002
    DUFFILL, Clare Marianne
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    Директор
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    British71005690002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Директор
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MAPP, Derek
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    Директор
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    British12473610001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Директор
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCQUARTER, Mark
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    British57915140001
    PICKERSGILL, John Barry
    Vale House
    Bourne Close Blind Lane
    SL8 5NG Bourne End
    Buckinghamshire
    Директор
    Vale House
    Bourne Close Blind Lane
    SL8 5NG Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish6145910001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish24300100007
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Директор
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SEGAL, Richard Lawrence
    11 Holly Park
    Finchley
    N3 3JA London
    Директор
    11 Holly Park
    Finchley
    N3 3JA London
    British47031800002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер2673413
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Guarantee and debenture
    Создан 03 сент. 2000 г.
    Поставлен 15 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H l/h land k/a bill brewer second avenue centrum 100 wellington road burton on trent t/no SF349440, joplins unit 30 low pavement chesterfield derbyshire t/no DY239637 and master locksmith meteor centre mansfield road derbyshire t/no DY203879 (for full details of all property charged see form 395) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Транзакции
    • 15 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 мар. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 28 апр. 1995 г.
    Поставлен 02 мая 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a guarantee and debenture dated 10 march 1994
    Краткое описание
    By way of legal mortgage all that property k/as the bill brewer public house centrum 100 burton upon trent.t/no.SF349440.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 мая 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 авг. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 10 мар. 1994 г.
    Поставлен 14 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of th e other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agereement and/or the swap agreements (each as defined therein)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Lenders and the Swap Counterparties as Defined Therein
    Транзакции
    • 14 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 10 мар. 1994 г.
    Поставлен 14 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All moneys standing to the credit of the accounts of the companies as per form 395.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 14 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 авг. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 15 окт. 1993 г.
    Поставлен 20 окт. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company & tom cobleigh PLC to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The old queens head pond hill sheffield.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 окт. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 16 сент. 1993 г.
    Поставлен 01 окт. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or tom cobleigh PLC to the chargee
    Краткое описание
    Master locksmith (formerly k/a the meteor centre)mansfield road derby.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 01 окт. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 25 мая 1993 г.
    Поставлен 07 июн. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and tom cobleigh limited to the chargee
    Краткое описание
    The red lion hotel market place doncaster south yorkshire.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 июн. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 12 мая 1993 г.
    Поставлен 15 мая 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The waggon & horses,abbeydale rd,millhouses,sheffield.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 15 мая 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Letter of charge
    Создан 21 апр. 1993 г.
    Поставлен 07 мая 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and the borrowers (as defined therein) to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All monies standing to the credit of the account or accounts of the company.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 мая 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 05 янв. 1993 г.
    Поставлен 12 янв. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or tom cobleigh limited to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The crofts quarry hill mosborough sheffield.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 12 янв. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 15 июл. 1992 г.
    Поставлен 25 июл. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from thecompany and/or tom cobleigh limited to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Joplins unit 30 the pavements chesterfield.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 25 июл. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 06 мая 1992 г.
    Поставлен 22 мая 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or any of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 22 мая 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 апр. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 06 мая 1992 г.
    Поставлен 19 мая 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company or any other group company to the chargee or any other member of the scottish & newcastle PLC group of companies under the terms of the facility agreement and/or any of the financing documents (as defined) and under or pursuant to the trading agreement
    Краткое описание
    (For full details see form 395 tc ref: M198C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Scottish & Newcastle PLC
    Транзакции
    • 19 мая 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 апр. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    12 янв. 2017 г.Начало ликвидации
    15 апр. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Практик
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Практик
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0