NPS (UK1) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииNPS (UK1) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02703539
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель NPS (UK1) LIMITED?

    • Прочие виды деятельности в области информационных технологий (62090) / Информация и связь

    Где находится NPS (UK1) LIMITED?

    Юридический адрес
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия NPS (UK1) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    NORTHGATE CSG LIMITED12 авг. 2003 г.12 авг. 2003 г.
    HAYS REDFERN LIMITED05 янв. 2000 г.05 янв. 2000 г.
    REDFERN CONSULTANCY LIMITED03 апр. 1992 г.03 апр. 1992 г.

    Каковы последние отчеты NPS (UK1) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались NPS (UK1) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницыLIQ13

    Юридический адрес изменен с Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW на 15 Canada Square London E14 5GL 03 мая 2019 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 03 апр. 2019 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    2 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 сент. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Ian Michael Noble в качестве директора 06 авг. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr Stephen James Callaghan 06 авг. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    3 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 сент. 2017 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Назначение Ian Michael Noble на должность директора 06 дек. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Coll в качестве директора 06 дек. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 8

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 9

    4 страницыMR04

    Назначение Mr Stephen James Callaghan на должность директора 10 окт. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David John Meaden в качестве директора 10 окт. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 сент. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital26 окт. 2015 г.

    Отчет о капитале на 26 окт. 2015 г.

    • Капитал: GBP 2,016,890
    SH01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed northgate csg LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name16 июн. 2015 г.

    Изменение наименования" по решению

    NM01
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Кто является должностными лицами NPS (UK1) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    CLIFF, David Ross
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Секретарь
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    British16556040001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Секретарь
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    FRASER, Neil Geoffrey
    21 Long Acre East
    Bingham
    NG13 8BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    21 Long Acre East
    Bingham
    NG13 8BY Nottingham
    Nottinghamshire
    English92567520001
    JONES, Richard Mark Lea
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    Секретарь
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    BritishAccountant41997740001
    LAYTON, Robert
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    Секретарь
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    British75448020002
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Секретарь
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Секретарь
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    Директор
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    BritishCompany Director95347040001
    CHARLTON, Keith Pearson
    Thatched Barn
    Hanslope Road Castlethorpe
    MK19 7HD Milton Keynes
    Northamptonshire
    Директор
    Thatched Barn
    Hanslope Road Castlethorpe
    MK19 7HD Milton Keynes
    Northamptonshire
    BritishExecutive Director51102460003
    CLIFF, David Ross
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Директор
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector16556040001
    CLIFF, Judith
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Директор
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector (Proposed)25534180001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    GORDON-JONES, Andrew
    Wiltshire House Uffcott
    Broad Hinton
    SN4 9NB Swindon
    Wiltshire
    Директор
    Wiltshire House Uffcott
    Broad Hinton
    SN4 9NB Swindon
    Wiltshire
    BritishDirector16556050002
    GORDON-JONES, Melanie
    2 Summerdale
    Aldbourne
    SN8 2LG Marlborough
    Wiltshire
    Директор
    2 Summerdale
    Aldbourne
    SN8 2LG Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector (Proposed)25534170001
    HODGSON, John Gordon
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    Директор
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    BritishCompany Director65293600001
    JONES, Richard Mark Lea
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    Директор
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant41997740001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive193740420001
    MOTTRAM, Malcolm John
    West End Barn Church Road
    Egleton
    LE15 8AD Oakham
    Leicestershire
    Директор
    West End Barn Church Road
    Egleton
    LE15 8AD Oakham
    Leicestershire
    BritishManaging Director42370680002
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    ROUTLEDGE, Craig Wilson
    Beechwood House
    Bevere Green
    WR3 7RG Worcester
    Директор
    Beechwood House
    Bevere Green
    WR3 7RG Worcester
    United KingdomBritishCompany Director78239540001
    SADLER, Christopher John
    Corinium House
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    Директор
    Corinium House
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector68996830001
    SADLER, Ursula Katherine
    Highcroft Hollies Hill
    Nailsworth
    GL6 0AW Stroud
    Glos
    Директор
    Highcroft Hollies Hill
    Nailsworth
    GL6 0AW Stroud
    Glos
    BritishDirector (Proposed)25534190001
    SMITH, James Peter
    Keepers Cottage
    Radmore Green Haughton
    CW6 9RL Tarporley
    Cheshire
    Директор
    Keepers Cottage
    Radmore Green Haughton
    CW6 9RL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishDirector49898310004
    SOWDEN, Michael Andrew
    Flat 3 Crete
    25 Ray Mill Road East
    SL6 8SW Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    Flat 3 Crete
    25 Ray Mill Road East
    SL6 8SW Maidenhead
    Berkshire
    BritishIt Business Developments63144130002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive66955690003
    WILSON, Philip William
    Paradise Farm
    Banbury Road
    NN11 6XY Lower Boddington
    Northamptonshire
    Директор
    Paradise Farm
    Banbury Road
    NN11 6XY Lower Boddington
    Northamptonshire
    BritishCompany Director69189630002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над NPS (UK1) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер00968498
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у NPS (UK1) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Security agreement
    Создан 25 апр. 2005 г.
    Поставлен 10 мая 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent)
    Транзакции
    • 10 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 дек. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security agreement
    Создан 22 янв. 2004 г.
    Поставлен 10 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The "Facility Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 10 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 дек. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Создан 13 апр. 1999 г.
    Поставлен 17 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the agreement (as defined) or otherwise
    Краткое описание
    All debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts between the chargee and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason.
    Уполномоченные лица
    • Griffin Credit Services Limited
    Транзакции
    • 17 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 февр. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 31 мар. 1999 г.
    Поставлен 13 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the bank (as defined in the senior facility agreement of even date) and/or the chargee (the security agent); as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined therein) under the terms of the senior finance documents (as defined threrein) or any other document; and all monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the mezzanine lenders (as defined therein) (or any of them) under the terms of the mezzanine finance documents (as defined therein) or any other document
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC(The Security Agent)
    Транзакции
    • 13 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 07 июл. 1997 г.
    Поставлен 08 июл. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £5,750 and interest due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The deposit account and all sums standing to the credit thereof (£5,750).
    Уполномоченные лица
    • Charles Michael Baron Faringdon
    Транзакции
    • 08 июл. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Third supplemental debenture
    Создан 30 мая 1997 г.
    Поставлен 04 июн. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the bank and/or the security agent under any of the senior finance documents (as defined) or any other document and all other obligatios and liabilities of eash obligor to the mezzanine lenders under the mezzanine finance documents (as defined) or any other document
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank Plcas Security Agent
    Транзакции
    • 04 июн. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession
    Создан 08 мая 1997 г.
    Поставлен 28 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the bank (as defined in the senior facility agreement of even date) and/or the chargee (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined therein) or any other document; and all monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the mezzanine lenders (as defined therein) (or any of them) under the terms of the mezzanine finance documents (as defined therein) or any other document
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 28 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 19 янв. 1995 г.
    Поставлен 31 янв. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 31 янв. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 09 дек. 1993 г.
    Поставлен 16 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 20TH august 1993 and this deed
    Краткое описание
    £2,750.00 in cash standing to the credit of a bank deposit account in the name of the landlord.
    Уполномоченные лица
    • Ian Kennedy
    Транзакции
    • 16 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у NPS (UK1) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    03 апр. 2019 г.Начало ликвидации
    01 февр. 2020 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0