GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02762842
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    • Разработка строительных проектов (41100) / Строительство

    Где находится GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Юридический адрес
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    KEEPEAGER LIMITED09 нояб. 1992 г.09 нояб. 1992 г.

    Каковы последние отчеты GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Каков статус последней годовой декларации для GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Изменение данных директора для Mr Colin Edward Lewis 22 окт. 2015 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Giles Henry Sharp 22 окт. 2015 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Joanne Elizabeth Massey 22 окт. 2015 г.

    1 страницыCH03

    Юридический адрес изменен с 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG на Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP 23 окт. 2015 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital23 окт. 2015 г.

    Отчет о капитале на 23 окт. 2015 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Прекращение полномочий Jon William Mortimore в качестве директора 31 мар. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Giles Sharp на должность директора 23 янв. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Neil Fitzsimmons в качестве директора 12 дек. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 2

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 10

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 11

    4 страницыMR04

    Изменение данных секретаря для Joanne Elizabeth Massey 15 дек. 2014 г.

    1 страницыCH03

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 окт. 2014 г.

    Отчет о капитале на 20 окт. 2014 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Прекращение полномочий Elizabeth Catchpole в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Jon William Mortimore на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital18 окт. 2013 г.

    Отчет о капитале на 18 окт. 2013 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    9 страницыAA

    legacy

    3 страницыMG02

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Кто является должностными лицами GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Секретарь
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807760001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Директор
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Директор
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Секретарь
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Секретарь
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Секретарь
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, David Charles
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    Директор
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    British35117370001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Директор
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    Директор
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Директор
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Директор
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Директор
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Директор
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Директор
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Директор
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Директор
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MARSHALL, Louis Daniel
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    Директор
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    United KingdomBritish152847400001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Директор
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Директор
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    British112119110001
    WEST, William Samuel
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Директор
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British35383900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Номинированный директор
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Есть ли у GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 30 дек. 2008 г.
    Поставлен 09 янв. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 09 янв. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 янв. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 14 июл. 2000 г.
    Поставлен 27 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 27 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 янв. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 18 дек. 1998 г.
    Поставлен 23 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Property k/a pymore bridport in the county of dorset t/n DT202773, DT207080, DT229615 & DT207062. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 23 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 нояб. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    First party commercial legal charge
    Создан 17 сент. 1996 г.
    Поставлен 20 сент. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H little hamonds farm london road burgess hill east sussex t/no SX116439 fixed charge all buildings and other structures fixed charge asigns of goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 сент. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 03 нояб. 1995 г.
    Поставлен 08 нояб. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a moorfields mill lane south holmwood surrey t/n SY599533, allbuildings structures items plant and machinery, goodwill, rentals claims under insurance policies relating or fixed to the property, floating charge over unattached plant machinery chattels and goods in connection with the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 нояб. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Assignment of life policy
    Создан 26 сент. 1995 г.
    Поставлен 11 окт. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Lloyd's life policy no 551/N3AA079 together with all rights, title, interests and accreations thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 11 окт. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 07 сент. 1995 г.
    Поставлен 20 сент. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    58 maywater close sanderstead surrey t/no: TGL304052. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 сент. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 18 авг. 1995 г.
    Поставлен 29 авг. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H land k/a 5 and 5A hawthorne place and 9 linden place epsom surrey t/n's SY643611,SY364122 and SY80306. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 29 авг. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Life policy assignation
    Создан 20 мая 1994 г.
    Поставлен 02 июн. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Lloyds underwriters :cygnet life policy no.:risk no.N3AAO79 together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 июн. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 30 нояб. 1993 г.
    Поставлен 07 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 янв. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 30 нояб. 1993 г.
    Поставлен 07 дек. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a santa tecla stanstead caterham surrey t/n SY399840. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 дек. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0