ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02834015
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    • Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки (64999) / Финансовая и страховая деятельность

    Где находится ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Юридический адрес
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    DAYREPORT LIMITED07 июл. 1993 г.07 июл. 1993 г.

    Каковы последние отчеты ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2015 г.

    Какие последние документы подавались ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    7 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 30 июл. 2018 г.

    11 страницыLIQ03

    Заявление о платежеспособности

    6 страницыLIQ01

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 31 июл. 2017 г.

    LRESSP

    Юридический адрес изменен с 135 Bishopsgate London EC2M 3UR на 250 Bishopsgate London EC2M 4AA 17 мар. 2017 г.

    1 страницыAD01

    Полное погашение обременения 4

    6 страницыMR04

    Полное погашение обременения 2

    9 страницыMR04

    Полное погашение обременения 3

    6 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    6 страницыMR04

    Полное погашение обременения 1

    6 страницыMR04

    Полное погашение обременения 7

    8 страницыMR04

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    Годовая бухгалтерская отчетность

    20 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 сент. 2016 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Полное погашение обременения 6

    7 страницыMR04

    Отчет о капитале на 20 мая 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    2 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Годовая бухгалтерская отчетность

    20 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital22 сент. 2015 г.

    Отчет о капитале на 22 сент. 2015 г.

    • Капитал: GBP 10,000,000
    SH01

    Назначение Rbs Secretarial Services Limited на должность секретаря 08 дек. 2014 г.

    2 страницыAP04

    Прекращение полномочий Elizabeth Lynxwiler в качестве секретаря 08 дек. 2014 г.

    1 страницыTM02

    Кто является должностными лицами ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Секретарь компании
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номерSC269847
    169073830001
    CATO, Guy Howard
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    7th Floor
    Директор
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    7th Floor
    EnglandBritishBank Official167340790001
    IRISH, Matthew Edward Alphage
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Директор
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official191076550001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Секретарь
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    LEA, John Albert
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    Секретарь
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    BritishSecretary1369400001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Секретарь
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    BritishBank Official1369400003
    LYNXWILER, Elizabeth
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Секретарь
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    169187130001
    SUTHERLAND, Ian Maclaren
    Littledean
    6 Squirrels Chase
    SK10 4YG Prestbury
    Cheshire
    Секретарь
    Littledean
    6 Squirrels Chase
    SK10 4YG Prestbury
    Cheshire
    British33119710003
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Секретарь
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOAG, Timothy John Donald
    St.Georges Road
    St Margaret's
    TW1 1QS East Twickenham
    23
    Middlesex
    England
    Директор
    St.Georges Road
    St Margaret's
    TW1 1QS East Twickenham
    23
    Middlesex
    England
    EnglandBritishBanker62111350003
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Директор
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    BritishBanker62111350002
    BROWNE, John Richard
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Директор
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishBank Official133984130002
    BURDETT, Wayne Francis
    18th Floor
    Repulse Bay Gardens, 32 Belleview Drive
    Hong Kong
    Директор
    18th Floor
    Repulse Bay Gardens, 32 Belleview Drive
    Hong Kong
    AustralianBank Official119566610001
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Директор
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Bank Director53756030002
    COMMONS, Peter Edmund
    The Paddock 14 Bedford Road
    MK44 3PS Willington
    Bedfordshire
    Директор
    The Paddock 14 Bedford Road
    MK44 3PS Willington
    Bedfordshire
    EnglandBritishBank Official269026820001
    CROME, Trevor Douglas
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    Директор
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    EnglandBritishBank Official186705800001
    DEVINE, Alan Sinclair
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Директор
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    United KingdomBritishHead: Risk & Portfolio Mgmt, Structured Fin148842310001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Директор
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    BritishHead Of Risk And Portfolio96634670001
    GREENSHIELDS, John Fraser
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    Директор
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    BritishBanker62806730003
    HALL, Phillip James
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Директор
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    UkBritishBanker106668160001
    HAMILTON, Euan Graeme
    1b Saint Ninians Road
    EH12 8AP Edinburgh
    Директор
    1b Saint Ninians Road
    EH12 8AP Edinburgh
    ScotlandScottishBank Official96880890001
    HARDY, Thomas William
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    Директор
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    EnglandBritishManaging Director40359960002
    HOUSTON, Iain Arthur
    Maple End 10 Hollydell
    SG13 8BE Hertford
    Hertfordshire
    Директор
    Maple End 10 Hollydell
    SG13 8BE Hertford
    Hertfordshire
    BritishBank Official8019000001
    JAMESON, Andrew David
    20 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    Директор
    20 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    BritishBank Official110180400001
    JONES-MOLYNEUX, Darren Scott
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    Директор
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    EnglandBritishBank Official152191300001
    JORDAN, Nicholas Mark
    43 Priory Road
    TW9 3DQ Kew
    Surrey
    Директор
    43 Priory Road
    TW9 3DQ Kew
    Surrey
    United KingdomBritishBank Official114291290001
    LEA, John Albert
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    Директор
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    BritishBank Official1369400001
    MADDICK, Kevin John
    Ringford Road
    West Hill
    SW18 1RS London
    16
    London
    England
    Директор
    Ringford Road
    West Hill
    SW18 1RS London
    16
    London
    England
    United KingdomBritishBank Official94650970001
    MCCARTHY, Fiona Louise
    Stock Road
    CM4 9PQ Stock
    Kauri Cottage
    England
    Директор
    Stock Road
    CM4 9PQ Stock
    Kauri Cottage
    England
    BritishHead Of Cib Finance103928910001
    MCGRANE, Joseph
    White Lodge
    Erskine Road
    EH31 2DQ Gullane
    East Lothian
    Директор
    White Lodge
    Erskine Road
    EH31 2DQ Gullane
    East Lothian
    United KingdomBritishInvestment Banker125934450001
    MORRIS, Philip Taylor
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    Директор
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    BritishChartered Accountant35386590001
    MORSE, Lee Robert
    5a Copers Cope Road
    BR3 1PB Beckenham
    Flat 13
    Kent
    Директор
    5a Copers Cope Road
    BR3 1PB Beckenham
    Flat 13
    Kent
    EnglandBritishBank Official141078840001
    MUDAN, Hurbinder Singh
    Hyde Vale
    Greenwich
    SE10 8QQ London
    27
    England
    Директор
    Hyde Vale
    Greenwich
    SE10 8QQ London
    27
    England
    EnglandBritishBank Official133983900001
    NAWAS, Michael Eugene, Dr
    Maynes Farmhouse
    Gorhambury
    AL3 6AF St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    Maynes Farmhouse
    Gorhambury
    AL3 6AF St Albans
    Hertfordshire
    DutchBank Official108365160001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 апр. 2016 г.
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    Нет
    Организационно-правовая формаPublic Limited Company
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCompanies Act 1948
    Место регистрацииRegister Of Members
    Регистрационный номерSc090312
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Account charge
    Создан 29 июл. 2009 г.
    Поставлен 06 авг. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296163, see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Consort Healthcare (Birmingham) Limited
    Транзакции
    • 06 авг. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Account charge
    Создан 29 июл. 2009 г.
    Поставлен 06 авг. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296171, see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Consort Healthcare (Mid Yorkshire) Limited
    Транзакции
    • 06 авг. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 сент. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of pledge
    Создан 22 дек. 2000 г.
    Поставлен 04 янв. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from northlink orkney and shetland ferries limited to the chargee under the terms of any secured document
    Краткое описание
    The pledgor hereby pledges charges assigns in favour of and transfers to the security trustee for the benefit of and on behalf of itself and the secured creditors the exisiting shares (and the proceeds of sale thereof) and any other charged assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 04 янв. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of pledge
    Создан 30 мар. 1999 г.
    Поставлен 01 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from kinnoull house limited to the chargee under the deed and/or under the loan agreement
    Краткое описание
    The existing shares and the proceeds of sale thereof and any other charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 01 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of pledge
    Создан 12 июн. 1998 г.
    Поставлен 26 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and liabilities present and future of covesea limited to the chargee under the terms of the loan agreement of even date, or any of the other financing documents other than the subordinated loan agreements and/or any deed or document supplemental thereto
    Краткое описание
    The existing shares (and the proceeds of sale thereof), of covesea and any other charged assets to which the pledgors are entitled at the date of the deed and any rights or further shares (and proceeds of sale thereof) to which they become entitled after the date of the deed (rights being all rights (including the right to receive all dividends and other distributions and bonus and scrip rights) pertaining to or deriving from the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Banks,as Defined)
    Транзакции
    • 26 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Charges on shares
    Создан 25 нояб. 1996 г.
    Поставлен 13 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities of tcl to the chargee under each of the operative documents to which tcl is a party and all present and future obligations of the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the charge on shares
    Краткое описание
    466,593 shares of £1 each in the capital of tcl and 297,454 shares of £1 each in the capital of tcl together with all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard Venture Leasing Limited
    Транзакции
    • 13 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Charge on shares
    Создан 25 нояб. 1996 г.
    Поставлен 12 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any finance party (as defined) and/or hedging bank (as defined) under each finance document (as defined) and all present and future obligations and liabilities of the company to any finance party and/or hedging bank under this charge on shares
    Краткое описание
    During the first security period, the 466,598 shares in the capital of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Dai-Ichi Kangyo Bank Limited, as Security Agent and Trustee for the Finance Parties and Thehedging Banks
    Транзакции
    • 12 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    31 июл. 2017 г.Начало ликвидации
    18 янв. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0