TWEED PREMIER 3 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTWEED PREMIER 3 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02847988
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    • (7011) /

    Где находится TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Юридический адрес
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    FUTURECOIN PUBLIC LIMITED COMPANY25 авг. 1993 г.25 авг. 1993 г.

    Каковы последние отчеты TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2009 г.

    Какие последние документы подавались TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Andrew Jones в качестве директора

    1 страницыTM01

    Отчет о капитале на 15 апр. 2010 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    legacy

    3 страницыMG02

    Прекращение полномочий Timothy Roberts в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Nigel Webb в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий James Taylor в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Lucinda Bell в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Peter Clarke в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Sarah Barzycki в качестве директора

    1 страницыTM01

    Изменение данных секретаря для Ndiana Ekpo 01 окт. 2009 г.

    1 страницыCH03

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    legacy

    5 страницы363a

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    legacy

    5 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    3 страницы363a

    Кто является должностными лицами TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Секретарь
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Директор
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Секретарь
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Секретарь
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Секретарь
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    Секретарь
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    British50515040002
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Секретарь
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Секретарь
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Секретарь
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Секретарь
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    British106162380001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Секретарь
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Секретарь
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Секретарь
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THE BRITISH LINEN BANK LIMITED
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    Секретарь компании
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    41450001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Директор
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BAMBER, Roger Stanley
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish2419370002
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Директор
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Директор
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Директор
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Директор
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    United KingdomBritish59208430002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Директор
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Директор
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLLINS, Roger
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    Директор
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    British45885520003
    CRUICKSHANK, James Kerr
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Директор
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British46894940001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Директор
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Директор
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Директор
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Директор
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    ScotlandBritish1127070001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Директор
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Директор
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Директор
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001
    ONEIL, James Charles
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    Директор
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    British63521290001
    RADLEY, Alan John
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    Директор
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    British80260530001
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Директор
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003

    Есть ли у TWEED PREMIER 3 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 17 сент. 2003 г.
    Поставлен 30 сент. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    26 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108953, 16 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108956, 24 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108960 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 сент. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Создан 11 сент. 2003 г.
    Поставлен 23 нояб. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    195 mains drive erskine t/no REN27597 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Транзакции
    • 23 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Создан 11 сент. 2003 г.
    Поставлен 23 нояб. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    12 the oaks killearn t/no STG10016 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Транзакции
    • 23 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 мар. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 31 дек. 2002 г.
    Поставлен 09 янв. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society
    Транзакции
    • 09 янв. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 дек. 2002 г.
    Поставлен 09 янв. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    (I) plot 2,beck riggs,brampton CU108956; (ii) flat 1,23 lansdowne rd,purley; SGL577213; (iii) 51 azalea close,ilford; EGL335123; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society,as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Транзакции
    • 09 янв. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Создан 30 дек. 2002 г.
    Поставлен 04 февр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    195 mains drive erskine PA8 7JN title number REN27597.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Транзакции
    • 04 февр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Создан 30 дек. 2002 г.
    Поставлен 04 февр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    12 the oaks killearn title number STG10016.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Транзакции
    • 04 февр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0