MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииMAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02936861
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    • Сбор, очистка и подача воды (36000) / Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по очистке

    Где находится MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Юридический адрес
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    MAPLIN ENVIRONMENTAL LIMITED08 июн. 1994 г.08 июн. 1994 г.

    Каковы последние отчеты MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 авг. 2015 г.

    Какие последние документы подавались MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01
    A5JHMX2O

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital24 июн. 2016 г.

    Отчет о капитале на 24 июн. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01
    X59RT0H4

    Юридический адрес изменен с 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP на 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR 15 июн. 2016 г.

    1 страницыAD01
    X596UDXT

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    3 страницыAA
    X57DJO00

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01
    X4EN8JMP

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital26 июн. 2015 г.

    Отчет о капитале на 26 июн. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01
    X4AB22BF

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY England на 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 страницыAD02
    X4AB21ZT

    Регистры перемещены по юридическому адресу 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 страницыAD04
    X4AB2201

    Назначение Mr Hugh Francis Edmonds на должность секретаря 14 мая 2015 г.

    2 страницыAP03
    X47HFP5K

    Прекращение полномочий John William Charles Charlton в качестве секретаря 30 апр. 2015 г.

    1 страницыTM02
    X47HE0ZE

    Прекращение полномочий John William Charles Charlton в качестве директора 30 апр. 2015 г.

    1 страницыTM01
    X47HE0R7

    Юридический адрес изменен с Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY на 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP 01 апр. 2015 г.

    1 страницыAD01
    X44DG6JL

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA
    A3N3PCW1

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital15 июн. 2014 г.

    Отчет о капитале на 15 июн. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01
    X3A33Y8W

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA
    A2OF2IBD

    Полное погашение обременения 9

    4 страницыMR04
    A2J2PT7E

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    X2BH6CYY

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA
    A239GGG2

    Прекращение полномочий John Prowse в качестве директора

    1 страницыTM01
    X1ZZ7P9L

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    X1B0SM4Y

    Изменение данных секретаря для John William Charles Charlton 07 июн. 2012 г.

    2 страницыCH03
    X1B0SM3V

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с 7-11 Nelson Street Southend on Sea Essex SS1 1EH

    1 страницыAD02
    X1B0SM4I

    Изменение данных директора для Mr Richard Hodgson 07 июн. 2012 г.

    2 страницыCH01
    X1B0SM4B

    Кто является должностными лицами MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    EDMONDS, Hugh Francis
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Секретарь
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    197706140001
    HODGSON, Richard George
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    Директор
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    EnglandBritishFinance Director155847280001
    BETTS, Andrew Graham
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    Секретарь
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    British74184230002
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Секретарь
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    BritishSales Director94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Секретарь
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    British151170420001
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Секретарь
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    BritishAccountant43888390002
    HOLLAND, James Lindsay
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    Секретарь
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    British71288860001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    Секретарь
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    British41940890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Номинированный секретарь
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Директор
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishSales Director94118060001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Директор
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Директор
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector - Shared Services119598150002
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Директор
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant43888390002
    FAULDS, Alistair
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    Директор
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    BritishWater Services Contractor39299610002
    HOLLAND, James Lindsay
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    Директор
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director71288860002
    HOLLAND, Mabel Grace
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    Директор
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    BritishCompany Secretary41940950001
    LEE, Michael William
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    Директор
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector66729790001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    Директор
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    BritishContract Manager41940890002
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    Директор
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    EnglandBritishChief Executive Officer96786510001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Номинированный директор
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Есть ли у MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 30 апр. 2010 г.
    Поставлен 12 мая 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 12 мая 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 15 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 21 авг. 2000 г.
    Поставлен 31 авг. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 31 авг. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Создан 04 авг. 2000 г.
    Поставлен 05 авг. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Краткое описание
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 05 авг. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 10 авг. 1998 г.
    Поставлен 27 авг. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and pursuant to or in connection with a financing agreement (as therein defined) and on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Close Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 27 авг. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 18 мар. 1998 г.
    Поставлен 25 мар. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a 19 sirdar road raylthe goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 25 мар. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 06 мар. 1998 г.
    Поставлен 11 мар. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 11 мар. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security interest agreement
    Создан 02 мар. 1998 г.
    Поставлен 10 мар. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All sums now and in the future credited to account number/designation Q999-1 held by the company with the royal bank of scotland international limited or any account which derives in whole or in part from such account.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 10 мар. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 февр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Создан 26 авг. 1997 г.
    Поставлен 05 сент. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debts or debts which were then or thereafter owing to the company on the account or accounts number 7125695 and all interest (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 05 сент. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 июл. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture deed
    Создан 29 апр. 1997 г.
    Поставлен 03 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 03 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 июл. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0