REDHOUSE PROJECTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииREDHOUSE PROJECTS LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02945476
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    • Разработка строительных проектов (41100) / Строительство

    Где находится REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Юридический адрес
    5th Floor Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SIMCO 641 LIMITED05 июл. 1994 г.05 июл. 1994 г.

    Каковы последние отчеты REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается30 июн. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены31 мар. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на24 июн. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено08 июл. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на24 июн. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Полное погашение обременения 1

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 2

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 3

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 9

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 8

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 4

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 7

    2 страницыMR04

    Изменение данных секретаря для Cromwell Corporate Secretarial Limited 04 февр. 2025 г.

    1 страницыCH04

    Изменение данных директора для Cromwell Director Limited 14 янв. 2025 г.

    1 страницыCH02

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 июн. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    13 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 июн. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Изменение данных директора для Mr James Edward Maddy 10 мая 2023 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Cromwell Director Limited 10 мая 2023 г.

    1 страницыCH02

    Изменение данных о Redhouse Holdings Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 10 мая 2023 г.

    2 страницыPSC05

    Юридический адрес изменен с 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU на 5th Floor Minerva House 29 East Parade Leeds LS1 5PS 10 мая 2023 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    12 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 июн. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Robert Stephen Jones в качестве директора 08 окт. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr James Edward Maddy на должность директора 08 окт. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    13 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 июн. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    13 страницыAA

    Кто является должностными лицами REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    STONEWEG CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1
    Scotland
    Секретарь компании
    Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1
    Scotland
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номерSC219311
    133355520025
    MADDY, James Edward
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Директор
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishHead Of Fund Accounting137459000002
    STONEWEG UK DIRECTOR LIMITED
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Директор компании
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер2945476
    102622300018
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Секретарь
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    CHETTLE, David
    51 Langton Road
    CV21 3UB Rugby
    Warwickshire
    Секретарь
    51 Langton Road
    CV21 3UB Rugby
    Warwickshire
    British39794800001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Секретарь
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Секретарь
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    MATTIN, David William
    Moonrakers
    Dark Lane Bliss Gate Rock
    DY14 9YN Kidderminster
    Worcestershire
    Секретарь
    Moonrakers
    Dark Lane Bliss Gate Rock
    DY14 9YN Kidderminster
    Worcestershire
    British2509430001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Секретарь
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Секретарь
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Секретарь
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    WILKINSON, Caroline Lesley
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Секретарь
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68331390001
    ZAJAC, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Секретарь
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320002
    SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Номинированный секретарь
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004040001
    BALES, Michael Howard
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    Директор
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director2645510001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Директор
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    BUTCHER, Roy
    2 Breydon Court
    Burton Upon Stather
    DN15 9DU Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Директор
    2 Breydon Court
    Burton Upon Stather
    DN15 9DU Scunthorpe
    North Lincolnshire
    BritishCompany Director364670002
    CHILD, Nicholas John
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    United Kingdom
    Директор
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146660790001
    CULLIFORD, Robert Malcolm
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    Директор
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director92567040001
    DIXON, George William
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    Директор
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    BritishCompany Director14883930006
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Директор
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director35528040001
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Директор
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishManager141515870001
    HOWE, Robert Philip Graham
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Директор
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish,Chartered Surveyor100940120001
    IVES, Simon George
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    Директор
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    EnglandBritishCompany Director18924830003
    JONES, Robert Stephen
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Директор
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishFund Accountant255392510003
    KENNEDY, Fraser James
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Директор
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant121610350001
    MARCUS, Anthony
    11 Queens Elm Square
    Old Church Street Chelsea
    SW6 3ED London
    Директор
    11 Queens Elm Square
    Old Church Street Chelsea
    SW6 3ED London
    BritishDirector59976230001
    MARTIN, Stephen Frederick
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    Директор
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    EnglandBritishDirector117868520002
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Директор
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Директор
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Директор
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector135717740001
    PATTISON, Ian
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Директор
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director160032140003
    POLLOCK, David Yewdall
    Manton
    50 Hawksworth Avenue
    LS20 8EJ Guiseley
    Leeds
    Директор
    Manton
    50 Hawksworth Avenue
    LS20 8EJ Guiseley
    Leeds
    BritishCompany Director34581320001
    RICHARDSON, Andrew Paul
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Директор
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor96498260002
    SANDERSON, Andrew James
    114a Church Street
    Netherthong
    HD9 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Директор
    114a Church Street
    Netherthong
    HD9 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    EnglandBritishProperty Developer50589920001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над REDHOUSE PROJECTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Redhouse Holdings Limited
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    06 апр. 2016 г.
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер3902049
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у REDHOUSE PROJECTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of charge over deposit
    Создан 02 мар. 2009 г.
    Поставлен 04 мар. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    First fixed charge its entire right,title and interest in and to the deposit see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 04 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    An assignment of charge and debts by way of security
    Создан 21 нояб. 2003 г.
    Поставлен 10 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The b&q unit, redhouse interchange, doncaster together with all sums secured by it, debts, together with all securities, assurances and other rights of the chargor.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 10 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 16 сент. 2003 г.
    Поставлен 01 окт. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a land at redhouse interchange doncaster south yorkshire part t/n SYK388389. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 01 окт. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 30 апр. 2003 г.
    Поставлен 07 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property land between roman ridge and the A638, redhouse interchange, doncaster, south yorkshire part of t/n SYK435891. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 04 февр. 2003 г.
    Поставлен 11 февр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a land at redhouse interchange doncaster south yorkshire part t/ns SYK388389 and SYK435891. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 11 февр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 12 дек. 2001 г.
    Поставлен 20 дек. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/Hold property known as land at the junction of the A1M and A638 ardwick le street,doncaster; part t/no syk 388389. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 20 дек. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 06 июл. 2001 г.
    Поставлен 17 июл. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The f/h property k/a land at the north side of longlands lane, brodsworth, doncaster, south yorkshire t/n SYK388389.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 июл. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 17 окт. 2000 г.
    Поставлен 19 окт. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a land at the junction of the A1M and the A638T at redhouse aldwick-le-street doncaster south yorkshire t/no: SYK388389. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 окт. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 14 сент. 2000 г.
    Поставлен 19 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 мар. 2025 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0