ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииENGINEERED SOLUTIONS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03004623
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    • Прочие отделочные работы (43390) / Строительство

    Где находится ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    Юридический адрес
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 нояб. 2013 г.

    Каков статус последней годовой декларации для ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    15 страницы4.71

    Назначение Mrs Laura Wilcock на должность секретаря 28 сент. 2015 г.

    2 страницыAP03

    Назначение Mr Robert Sloss на должность секретаря 28 сент. 2015 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Agnes Mary D'cruz в качестве секретаря 10 июн. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с C/O Agnes D'cruz United Technologies House Guildford Road Fetcham Leatherhead Surrey KT22 9UT England на United Technologies House Guildford Road Leatherhead Surrey KT22 9UT

    2 страницыAD02

    Юридический адрес изменен с United Technologies House Guildford Road Leatherhead Surrey KT22 9UT на Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR 07 сент. 2015 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 25 авг. 2015 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Назначение Mr Evan Smith на должность директора 25 июн. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Rajinder Kullar на должность директора 25 июн. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Christian Bruno Jean Idczak на должность директора 25 июн. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Steven Thomas Mcdonald в качестве директора 25 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Richard Hilton Jones в качестве директора 25 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital22 дек. 2014 г.

    Отчет о капитале на 22 дек. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с C/O Genevieve Mead United Technologies House Guildford Road Fetcham Leatherhead Surrey KT22 9UT England на C/O Agnes D'cruz United Technologies House Guildford Road Fetcham Leatherhead Surrey KT22 9UT

    1 страницыAD02

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 янв. 2014 г.

    Отчет о капитале на 20 янв. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Назначение Mr Richard Hilton Jones на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий James Whelan в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий David Moseley в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    Назначение Mr Steven Thomas Mcdonald на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Habib Hussain в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    SLOSS, Robert
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Секретарь
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    201319500001
    WILCOCK, Laura
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Секретарь
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    201319570001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Директор
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrenchTreasury Director192320890001
    KULLAR, Rajinder Singh
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Директор
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritishAccountant198928350001
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Директор
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,IrishInternational Tax Counsel73647690004
    D'CRUZ, Agnes Mary
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Секретарь
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British147167110001
    FARADAY, Mat
    4 Ember Lane
    KT10 8ER Esher
    Surrey
    Секретарь
    4 Ember Lane
    KT10 8ER Esher
    Surrey
    British118795280001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Номинированный секретарь
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    HARNETT, Kevin Michael
    Kensington Lodge
    11 Heathfield Road
    ME14 2AD Maidstone
    Kent
    Секретарь
    Kensington Lodge
    11 Heathfield Road
    ME14 2AD Maidstone
    Kent
    BritishDirector41557570002
    BATTERS, Paul Adrian
    20 Peregrine Drive
    ME10 4TZ Sittingbourne
    Kent
    Директор
    20 Peregrine Drive
    ME10 4TZ Sittingbourne
    Kent
    United KingdomBritishDirector41559490002
    FALAHEE, Peter Edmond
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    United KingdomBritishDirector147167420001
    FARADAY, Mat
    4 Ember Lane
    KT10 8ER Esher
    Surrey
    Директор
    4 Ember Lane
    KT10 8ER Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector118795280001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Номинированный директор
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HARNETT, Kevin Michael
    Kensington Lodge
    11 Heathfield Road
    ME14 2AD Maidstone
    Kent
    Директор
    Kensington Lodge
    11 Heathfield Road
    ME14 2AD Maidstone
    Kent
    BritishDirector41557570002
    HUSSAIN, Habib, Director
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    EnglandBritishDirector90390650003
    JONES, Richard Hilton
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director101090610001
    MCDONALD, Steven Thomas
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director133653510001
    MOSELEY, David George
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    EnglandBritishDirector110058560001
    OBAFEMI, Gboyega
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    Utc House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    Utc House
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director204062780001
    OVERMAN, Kerry Mark
    One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    2
    Bucks
    Uk
    Директор
    One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    2
    Bucks
    Uk
    United KingdomBritishDirector138389650001
    WESTON, Philip Richard
    8 Sharon Road
    W4 4PD London
    Директор
    8 Sharon Road
    W4 4PD London
    United KingdomBritishDirector81224690001
    WHELAN, James Michael
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    Директор
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    EnglandIrishManaging Director156635090001

    Есть ли у ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Fixed and floating charge
    Создан 25 июл. 2006 г.
    Поставлен 27 июл. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 27 июл. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 нояб. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 24 мар. 2003 г.
    Поставлен 27 мар. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 27 мар. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 апр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 08 мая 2002 г.
    Поставлен 14 мая 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a 2 north court, armstrong road, maidstone, kent ME15 6JZ. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Bank PLC
    Транзакции
    • 14 мая 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 05 янв. 1995 г.
    Поставлен 07 янв. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 07 янв. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у ENGINEERED SOLUTIONS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    25 авг. 2015 г.Начало ликвидации
    25 апр. 2016 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0