CALVERSIDE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCALVERSIDE LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03004833
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CALVERSIDE LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится CALVERSIDE LIMITED?

    Юридический адрес
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты CALVERSIDE LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2012 г.

    Каков статус последней годовой декларации для CALVERSIDE LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались CALVERSIDE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital03 янв. 2014 г.

    Отчет о капитале на 03 янв. 2014 г.

    • Капитал: GBP 1,000
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Изменение данных директора для Jeffrey William Adams 31 мая 2013 г.

    2 страницыCH01

    Прекращение полномочий Victoria Haynes в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Прекращение полномочий Simon Jones в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Назначение Mr Simon David Ainslie Jones на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Mickleburgh в качестве директора

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Kevin Barry Duggan 08 мар. 2012 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Jeffrey William Adams 08 мар. 2012 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Victoria Haynes 08 мар. 2012 г.

    1 страницыCH03

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01

    Решения

    Resolutions
    25 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01
    capital

    Решения

    The directors of the co are authorised to raise an aggregate sum of £2400000 by the creation and issue of loan notes each of a denomination of £100000 bearing interest at the rate of 1.5%/the entry by the co into the shareholders agreement be approved/the fixed and floating charges to be granted by the co as security for loans 03/05/1995
    RES13

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    Прекращение полномочий Andrew Mickleburgh в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Andrew Simon Mickleburgh на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Andrew Simon Mickleburgh на должность директора

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Кто является должностными лицами CALVERSIDE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    ADAMS, Jeffrey William
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Директор
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    United KingdomBritishDirector3480850002
    DUGGAN, Kevin Barry
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Директор
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    EnglandBritishAccountant5330260003
    CROSS, Stephen
    2 Breach Cottages
    Breach Lane Upchurch
    ME9 7PE Sittingbourne
    Kent
    Секретарь
    2 Breach Cottages
    Breach Lane Upchurch
    ME9 7PE Sittingbourne
    Kent
    British3480870003
    CROSS, Stephen
    Winterbourne Wrens Road
    Borden
    ME9 8JD Sittingbourne
    Kent
    Секретарь
    Winterbourne Wrens Road
    Borden
    ME9 8JD Sittingbourne
    Kent
    BritishChartered Accountant3480870002
    CROSS, Stephen
    Winterbourne Wrens Road
    Borden
    ME9 8JD Sittingbourne
    Kent
    Секретарь
    Winterbourne Wrens Road
    Borden
    ME9 8JD Sittingbourne
    Kent
    BritishChartered Accountant3480870002
    DRIVER, Elaine Anne
    134 Lennard Road
    BR3 1QP Beckenham
    Kent
    Секретарь
    134 Lennard Road
    BR3 1QP Beckenham
    Kent
    BritishSolicitor97041650002
    HARWOOD, Keith Anthony Reginald
    32 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Секретарь
    32 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    British29167420004
    HAYNES, Victoria
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Секретарь
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    British126947630001
    RYAN, John Benedict
    1 Leather Lane
    Gomshall
    GU5 9NB Guildford
    Surrey
    Секретарь
    1 Leather Lane
    Gomshall
    GU5 9NB Guildford
    Surrey
    BritishCh Accountant70736030001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный секретарь
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    DUGGAN, Kevin Barry
    1 Ash Tree Court
    Ash Tree Drive
    TN15 6LT West Kingsdown
    Kent
    Директор
    1 Ash Tree Court
    Ash Tree Drive
    TN15 6LT West Kingsdown
    Kent
    EnglandBritishAccountant5330260003
    HAMMERSON, Charles Brian
    1 Hook Lane
    EN6 4DA Northaw
    Hertfordshire
    Директор
    1 Hook Lane
    EN6 4DA Northaw
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director46062310003
    JONES, Simon David Ainslie
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Директор
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    United KingdomBritishGroup Finance Director156250090001
    MICKLEBURGH, Andrew Simon
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Директор
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    EnglandBritishCompany Director61711010004
    MICKLEBURGH, Andrew Simon
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    Директор
    United House
    Goldsel Road
    BR8 8EX Swanley
    Kent
    EnglandBritishCompany Director61711010004
    SNUGGS, Philip
    South Farm House
    BA12 7BB North Bavant
    Wiltshire
    Директор
    South Farm House
    BA12 7BB North Bavant
    Wiltshire
    BritishAccountant30997090001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный директор
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Есть ли у CALVERSIDE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 08 июл. 1996 г.
    Поставлен 17 июл. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from united house limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 21ST june 1996 or this debenture
    Краткое описание
    F/H property k/a bishops depository, 10 and 12 belgrave road and land adjoining and 4 hugh street t/no. NGL272158. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 17 июл. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 сент. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Agreement
    Создан 19 июн. 1996 г.
    Поставлен 10 июл. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan notes issued to the chargee pursuant to a shareholders agreement dated 3/5/95
    Краткое описание
    All monies in an account in the joint names of goodman derrick and winward fearon at national westminster bank PLC cavendish square branch.
    Уполномоченные лица
    • Deancourt Management (UK) Limited
    Транзакции
    • 10 июл. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 июн. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 03 мая 1995 г.
    Поставлен 17 мая 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the loan notes dated 3/5/95
    Краткое описание
    Legal mortgage over 4 hugh street forming part of the land under t/no 229835 10/12 belgrave road london SW1T/no 261314 and land adjoining 10/12/ belgrave road london SW1 with f/h title under t/no NGL704603 and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • United House Limited
    Транзакции
    • 17 мая 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 июн. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 03 мая 1995 г.
    Поставлен 17 мая 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the loan notes dated 3/5/95
    Краткое описание
    Fixed charge all right title estate and other interests of the company IN4 hugh street t/no 229835 and 10/12 belgrave road london SW1 t/no 261314 and land adjoining 10/12/ belgrave road london SW1 t/no NGL704603 and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deancourt Management UK Limited
    Транзакции
    • 17 мая 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 авг. 1996 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 27 июн. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 28 февр. 1995 г.
    Поставлен 03 мар. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this mortgage
    Краткое описание
    Bishop's depository 4 high street london SW1 comprising:- f/h land and buildings k/a 10 and 12 belgrave road t/n 261314, f/h land adjoining 10 and 12 belgrave road t/n NGL704603 and f/h land k/a 4 high street forming part of the land under t/n 229835.
    Уполномоченные лица
    • Deancourt Management Corp
    Транзакции
    • 03 мар. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 июн. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0