EURO SALES FINANCE LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииEURO SALES FINANCE LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03038707
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель EURO SALES FINANCE LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Юридический адрес
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    EURO SALES FINANCE PLC28 мар. 1995 г.28 мар. 1995 г.

    Каковы последние отчеты EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2017 г.

    Какие последние документы подавались EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    7 страницыLIQ13

    Заявление о платежеспособности

    6 страницыLIQ01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 12 июн. 2020 г.

    LRESSP

    Полное погашение обременения 9

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 8

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 3

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 2

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 1

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 10

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 7

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 11

    4 страницыMR04

    Предыдущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Уведомление о подтверждении, составленное 09 сент. 2019 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 03 июн. 2019 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Свидетельство о перерегистрации с акционерного общества на общество с ограниченной ответственностью

    1 страницыCERT10

    Перерегистрация Меморандума и Устава

    28 страницыMAR

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение о перерегистрации

    RES02

    Перерегистрация публичной компании в частную компанию с ограниченной ответственностью

    1 страницыRR02

    Кто является должностными лицами EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Секретарь компании
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номерSC269847
    169073830001
    PARRY, Alan David
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    Директор
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official230732060001
    PATTARA, Joseph Alexander
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    Директор
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official218232410001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Секретарь
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Секретарь
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    HARTLEY, Steven Michael
    21 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Cheshire
    Секретарь
    21 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Cheshire
    BritishCompany Secretary/Director80734990001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Секретарь
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    VERRILL, John Rothwell
    Fishponds
    Ferry Road, South Stoke
    RG8 0JP Reading
    Berkshire
    Секретарь
    Fishponds
    Ferry Road, South Stoke
    RG8 0JP Reading
    Berkshire
    British40921770003
    WINN, Ian David
    71 Squires Wood
    PR2 9QA Preston
    Lancashire
    Секретарь
    71 Squires Wood
    PR2 9QA Preston
    Lancashire
    BritishAccountant94350900001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Номинированный секретарь
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    ARVIS, Jean Albert
    176 Boulevard St
    Germain
    FOREIGN Paris
    75006
    Директор
    176 Boulevard St
    Germain
    FOREIGN Paris
    75006
    FrenchHonorary Chairman Of French In55082120003
    BARDRICK, Michael Jeffrey
    Smith House
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Rbs Invoice Finance
    Директор
    Smith House
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Rbs Invoice Finance
    EnglandBritishBank Official97155410002
    BARNARD, Andrew David
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    Директор
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    EnglandBritishBank Official137736080001
    BEVAN, James John
    31 Moor Hill
    Norden
    OL11 5YB Rochdale
    Lancashire
    Директор
    31 Moor Hill
    Norden
    OL11 5YB Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishBank Official107029910001
    BLAND, James
    28a Warrington Crescent
    W9 1EL London
    Директор
    28a Warrington Crescent
    W9 1EL London
    BritishCompany Executive66823120001
    BRADLEY, Neil Joseph
    Neidpath
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Директор
    Neidpath
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBank Official85614780002
    BRUCKMANN, Horst
    Bonscheidter Strasse 73d
    Essen
    FOREIGN Nrw
    45259
    Germany
    Директор
    Bonscheidter Strasse 73d
    Essen
    FOREIGN Nrw
    45259
    Germany
    GermanBanker64246420001
    BURGUM, Judith Helen
    1 The Walled Garden
    Swinton
    M27 0FR Manchester
    Lancashire
    Директор
    1 The Walled Garden
    Swinton
    M27 0FR Manchester
    Lancashire
    BritishAccountant68795100001
    CHAMBERS, Antony Craven
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    Директор
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishBanker94516690001
    COULON, Patrice Pierre Michel
    8 Bis Rue Jeanne D Arc
    St Germainenlaye
    78100
    Yvelines
    France
    Директор
    8 Bis Rue Jeanne D Arc
    St Germainenlaye
    78100
    Yvelines
    France
    FrancaiseDirector64246550001
    COWIE, Ian Duncan
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    Директор
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official195617950001
    COWIE, Ian Duncan
    30 Anvil Way
    CM1 6SZ Chelmsford
    Essex
    Директор
    30 Anvil Way
    CM1 6SZ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishHead Of Specialist Corporate B195617950001
    DICKINSON, Alan Peter
    TN5
    Директор
    TN5
    EnglandBritishBank Official190869750001
    ELLIOT, Graeme Arthur
    Garden Flat 2 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    Директор
    Garden Flat 2 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    BritishChartered Accountant40491120002
    FITZ-HARRIS, Robert Ian
    Halton House
    20/23 Holborn
    EC1N 2JB London
    Директор
    Halton House
    20/23 Holborn
    EC1N 2JB London
    BritishAccountant/Company Director74290240002
    GEORG, Gerd
    In Den Rohrwiesen 15a
    Harxheim
    52296
    Germany
    Директор
    In Den Rohrwiesen 15a
    Harxheim
    52296
    Germany
    GermanEconomist74254680001
    HAISMAN, Keith
    The Brick House
    Hermitage Meadow
    CO10 8QQ Clare
    Suffolk
    Директор
    The Brick House
    Hermitage Meadow
    CO10 8QQ Clare
    Suffolk
    EnglandBritishBanker150598270001
    HAMMOND CHAMBERS, Robert Alexander
    3 Liberton Tower Lane
    EH16 6TQ Edinburgh
    Midlothian
    Директор
    3 Liberton Tower Lane
    EH16 6TQ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishCompany Director86215110001
    HANNAY, Melanie Jane
    35 Belgrave Road
    BN25 2EN Seaford
    East Sussex
    Директор
    35 Belgrave Road
    BN25 2EN Seaford
    East Sussex
    EnglandBritishBank Official120022180001
    HARTLEY, Steven Michael
    21 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Cheshire
    Директор
    21 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant80734990001
    HOLDEN, Adam
    Smith House
    PO BOX 343 Elmwood Avenue
    TW13 7WH Feltham
    Middlesex
    Директор
    Smith House
    PO BOX 343 Elmwood Avenue
    TW13 7WH Feltham
    Middlesex
    EnglandBritishBank Official185018800001
    HOLLOWAY, Stuart Antony
    1 Potters Close
    TN25 4PX Ashford
    Kent
    Директор
    1 Potters Close
    TN25 4PX Ashford
    Kent
    EnglandBritishBanker68311830002
    KOENEN, Edward Anthony Nicolas
    Koninginnelaan 5
    Heelsum
    6866 Nl
    The Netherlands
    Директор
    Koninginnelaan 5
    Heelsum
    6866 Nl
    The Netherlands
    DutchDirector77369960001
    LORD, Peter Edmund
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Директор
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishFinance House Manager195549570001
    MCFARLANE, Ross William
    Beacon Road
    Ringshall
    HP4 1NE Berkhamsted
    Badgers Wood
    Hertfordshire
    England
    Директор
    Beacon Road
    Ringshall
    HP4 1NE Berkhamsted
    Badgers Wood
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishSales Director54399140004

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над EURO SALES FINANCE LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    04 апр. 2018 г.
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основание1948
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер00662221
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    Rbs Invoice Finance (Holdings) Limited
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    06 апр. 2016 г.
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCompanies Act 1985
    Место регистрацииRegister Of Members
    Регистрационный номер04108349
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у EURO SALES FINANCE LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Assignment of loan documentation
    Создан 13 февр. 2007 г.
    Поставлен 28 февр. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All right title and inteerst in and to the facility agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hamsard 3000 Limited
    Транзакции
    • 28 февр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 окт. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Amendment and restatement agreement and confirmatory charge relating to a security trust agreement dated 3RD march 1999
    Создан 04 мая 2001 г.
    Поставлен 21 мая 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The aggregate of all monies and any other liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee on behalf of the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the overdraft facility, the facility agreement, the security trust agreement and/or any other transaction document (all as defined in the deed)
    Краткое описание
    Funded receivables - subject to the provisions of clause 8 of the security trust agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 мая 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 3RD march 1999
    Создан 04 мая 2001 г.
    Поставлен 16 мая 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 16 мая 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 апр. 2020 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Amended and restated security trust agreement (the security trust agreement) made between euro sales finance PLC, national westminster bank PLC (the security trustee), royal bank of canada fund managers (jersey) limited (the manager) and others as beneficiaries.
    Создан 16 окт. 2000 г.
    Поставлен 01 нояб. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the overdraft facility, the facility agreement, the security trust agreement and/or any other transaction document
    Краткое описание
    All its right, title, interest and benefit, present and future in and to the funded receivables the insurance policies each transaction document present and future in each of the collection accounts floating charge undertaking and all its property and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 01 нояб. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Rent deposit deed
    Создан 18 июл. 2000 г.
    Поставлен 20 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease assigned to the company
    Краткое описание
    £34,550 plus value added tax and any interest accruing thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Wardens and Commonalty of the Mystery of Mercers of the City of London
    Транзакции
    • 20 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security trust agreement (the security trust agreement) national westminster bank PLC (the security trustee) royal trust asset management (C.I.) limited (the manager) and the beneficiaries.
    Создан 03 мар. 1999 г.
    Поставлен 05 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the overdraft facility, the facility agreement, the security trust agreement and/or any other transaction document
    Краткое описание
    All its right, title, interest and benefit, present and future in and to the funded receivables the insurance policies each transaction document pesent and futures in each of the collection accounts floating charge undertaking and all its property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 03 мар. 1999 г.
    Поставлен 05 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 03 мар. 1999 г.
    Поставлен 05 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 05 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 апр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of assignment
    Создан 14 февр. 1996 г.
    Поставлен 16 февр. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a facility agreement dated 25/5/95 and/this charge
    Краткое описание
    Policies of insurance being life assured ian fitz-harris sum £1,000,000 policy no 2 767 615 insurer the canada life assurance company. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 16 февр. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Rental deposit deed
    Создан 25 авг. 1995 г.
    Поставлен 06 сент. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Краткое описание
    The initial deposit of £26,437.50.
    Уполномоченные лица
    • The Wardens and Commonalty of the Mystery of Mercers of the City of London
    Транзакции
    • 06 сент. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 21 июн. 1995 г.
    Поставлен 06 июл. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The secured obligations (as defined in the debenture) and all the other obligations of the company under the debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 06 июл. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 нояб. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у EURO SALES FINANCE LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    12 июн. 2020 г.Начало ликвидации
    10 сент. 2021 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0