THANET PRESS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTHANET PRESS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03051768
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель THANET PRESS LIMITED?

    • (2222) /

    Где находится THANET PRESS LIMITED?

    Юридический адрес
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия THANET PRESS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TERMVIEW LIMITED01 мая 1995 г.01 мая 1995 г.

    Каковы последние отчеты THANET PRESS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2008 г.

    Каков статус последней годовой декларации для THANET PRESS LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались THANET PRESS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    19 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 апр. 2015 г.

    16 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 апр. 2014 г.

    16 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 окт. 2012 г.

    17 страницы4.68

    Юридический адрес изменен с * C/O Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House 5 Clanricarde Gardens Tunbridge Wells Kent TN1 1PE United Kingdom* 29 нояб. 2012 г.

    2 страницыAD01

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 апр. 2012 г.

    18 страницы4.68

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    3 страницыF10.2

    Уведомление о создании ликвидационной комиссии

    2 страницы4.48

    Отчет о состоянии дел с приложенной формой 4.19

    13 страницы4.20

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации

    LRESEX

    Юридический адрес изменен с * Union Crescent Margate Kent CT9 1NU* 30 мар. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Процедура принудительной ликвидации прекращена

    1 страницыDISS40

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital12 окт. 2010 г.

    Отчет о капитале на 12 окт. 2010 г.

    • Капитал: GBP 792,000
    SH01

    Изменение данных директора для Peter Griffiths 01 мая 2010 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Phillip John Moore 01 мая 2010 г.

    2 страницыCH01

    Прекращение полномочий Robert Paynter в качестве директора

    1 страницыTM01

    Предыдущий отчетный период продлен

    3 страницыAA01

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    legacy

    5 страницыMG01

    Прекращение полномочий Peter Griffiths в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Peter Griffiths в качестве директора

    1 страницыTM01

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    5 страницыMG01

    Кто является должностными лицами THANET PRESS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MOORE, Phillip John
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    Директор
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    EnglandBritishOwner100657710001
    TONKIN, Kenneth William
    22 Port Hill Road
    SY3 8SA Shrewsbury
    High House
    Shropshire
    Директор
    22 Port Hill Road
    SY3 8SA Shrewsbury
    High House
    Shropshire
    EnglandBritishNone3099970003
    DOBBIN, Samuel David
    38 Glenbroome Park
    BT37 0RL Newtownabbey
    County Antrim
    Northern Ireland
    Секретарь
    38 Glenbroome Park
    BT37 0RL Newtownabbey
    County Antrim
    Northern Ireland
    IrishIrish56609460001
    LINDSAY, Kenneth George
    8 Kings Court
    Templepatrick
    BT39 0EB Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    Секретарь
    8 Kings Court
    Templepatrick
    BT39 0EB Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    BritishDirector32158570001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BAILIE, Robert Ernest
    60 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0QR Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    Директор
    60 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0QR Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishDirector23257550001
    BERRY, Roger Michael Harvey
    Lower House
    Chelworth
    SN16 9SF Malmesbury
    Wiltshire
    Директор
    Lower House
    Chelworth
    SN16 9SF Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishManager72069500001
    COOPER, Ian Victor
    7 Peal Close
    Hoo
    ME3 9HE Rochester
    Kent
    Директор
    7 Peal Close
    Hoo
    ME3 9HE Rochester
    Kent
    EnglandBritishSales69493260001
    DAVIS, Jane Clare
    5 Acre Grove
    Halling
    ME2 1BF Rochester
    Kent
    Директор
    5 Acre Grove
    Halling
    ME2 1BF Rochester
    Kent
    BritishFinance Director116446480001
    DURRANT, Craig Stuart
    Queens Avenue
    CT9 5SB Margate
    1
    Kent
    Директор
    Queens Avenue
    CT9 5SB Margate
    1
    Kent
    EnglandBritishSales Director135513680001
    EDDINGTON, Raymond
    Hilltop Biddenden Road
    Frittenden
    TN17 2EN Cranbrook
    Kent
    Директор
    Hilltop Biddenden Road
    Frittenden
    TN17 2EN Cranbrook
    Kent
    BritishSales Director45178700001
    FORD, David Graham
    1 Camelia Close
    CT9 5BX Margate
    Kent
    Директор
    1 Camelia Close
    CT9 5BX Margate
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director45178530001
    FORDHAM, Gary
    278 Longbanks
    CM18 7PD Harlow
    Essex
    Директор
    278 Longbanks
    CM18 7PD Harlow
    Essex
    BritishSales Director96704130001
    GRAY, Douglas Frederick
    5 Arolla Road
    Beltinge
    CT6 6BW Herne Bay
    Kent
    Директор
    5 Arolla Road
    Beltinge
    CT6 6BW Herne Bay
    Kent
    BritishWorks Director59608250001
    GRIFFITHS, Peter
    Prospect Road
    Minster
    CT12 4EG Margate
    25
    Kent
    Директор
    Prospect Road
    Minster
    CT12 4EG Margate
    25
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director135513770001
    HERBAGE, Karen Jane
    6 Nelson Road
    CT5 1DP Whitstable
    Kent
    Директор
    6 Nelson Road
    CT5 1DP Whitstable
    Kent
    BritishAccountant96704260001
    HURLEY, David Manuel
    The Cedars
    3 Hythe Road
    BN11 5DA West Worthing
    West Sussex
    Директор
    The Cedars
    3 Hythe Road
    BN11 5DA West Worthing
    West Sussex
    BritishManager105672040001
    LINDSAY, Kenneth George
    8 Kings Court
    Templepatrick
    BT39 0EB Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    Директор
    8 Kings Court
    Templepatrick
    BT39 0EB Ballyclare
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishDirector32158570001
    PAYNTER, Robert Leslie
    38 Wick Beech Avenue
    SS11 8AP Wickford
    Essex
    Директор
    38 Wick Beech Avenue
    SS11 8AP Wickford
    Essex
    United KingdomBritishAdvisor Chairman114111630001
    READ, Michael John
    5 Strathavon Close
    GU6 8PW Cranleigh
    Surrey
    Директор
    5 Strathavon Close
    GU6 8PW Cranleigh
    Surrey
    BritishNon Exec Director23250080001
    SAWARD, Geoffrey Raymond
    23 Lonsdale Avenue
    Cliftonville
    CT9 3BT Margate
    Kent
    Директор
    23 Lonsdale Avenue
    Cliftonville
    CT9 3BT Margate
    Kent
    BritishWorks Director7681140002
    THOMAS, Trevor Anthony
    23 Epple Bay Road
    CT7 9EN Birchington
    Kent
    Директор
    23 Epple Bay Road
    CT7 9EN Birchington
    Kent
    BritishFinancial Director42774240002
    THOMSON, John White
    2 Highfield Close
    OX9 2AY Thame
    Oxfordshire
    Директор
    2 Highfield Close
    OX9 2AY Thame
    Oxfordshire
    BritishNon Exec Director45178250002
    VAN WALWYK, Peter James
    93 Fairfield Road
    CT11 7BB Ramsgate
    Kent
    Директор
    93 Fairfield Road
    CT11 7BB Ramsgate
    Kent
    BritishOperations Director96704200001
    WALSH, Dominic Gerard
    18 Donegall Park Avenue
    BT15 4EU Belfast
    County Antrim
    Директор
    18 Donegall Park Avenue
    BT15 4EU Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritishDirector93982180001
    YATES, Peter
    45 Pledwick Lane
    WF2 6EA Wakefield
    West Yorkshire
    Директор
    45 Pledwick Lane
    WF2 6EA Wakefield
    West Yorkshire
    BritishOperations Director61698240005
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный директор
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Есть ли у THANET PRESS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 09 сент. 2010 г.
    Поставлен 15 сент. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Kenneth William Tonkin
    Транзакции
    • 15 сент. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 16 июн. 2010 г.
    Поставлен 18 июн. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All properties,all licences,consents and authorisations,the intellectual properties, see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Kenneth William Tonkin
    Транзакции
    • 18 июн. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Chattel mortgage
    Создан 21 мар. 2009 г.
    Поставлен 21 мар. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Assigns the equipment all policies of insurance in respect of the equipment benefit of all options and rights under any such policy of insurance. Komori lithrone 40 l-440 4 colour sheet fed offset lithographic printing press with semi automatic plate changing alchol damping technotrans chilling approx 55,050,000 impressions seriel no 2129 please see form 395 for further details of goods.
    Уполномоченные лица
    • Davenham Trust PLC
    Транзакции
    • 21 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 19 мар. 2009 г.
    Поставлен 21 мар. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed charge all estate or interest in any freehold /leasehold property uncalled capital goodwill trademarks trade names patents copyrights intellectual property stocks shares other securities book debts and other debts bank deposits floating chargee undertakings and assets see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Davenham Trust PLC
    Транзакции
    • 21 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Chattels mortgage
    Создан 02 нояб. 2006 г.
    Поставлен 03 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Heidelberg sm 102-5P3 72CM x 102CM 5 colour perfector offset lithographic printing machine no. 540041 muller martine 300-20 starbinder 20 clamp perfect binding line s/n 94.02431 comprising 1571 10 station gatherer transfer section with book block feeder for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 03 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 мая 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 20 окт. 2004 г.
    Поставлен 28 окт. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 28 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Chattels mortgage
    Создан 24 июн. 2004 г.
    Поставлен 25 июн. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All and singular the chattels plant machinery and things being 2001 komori lithrone l 440II (em) four colour offset printing press serial number 2129, 1998 heidelberg speedmaster SM102 two colour offset press model SM102-2P serial number 538684.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Транзакции
    • 25 июн. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 21 авг. 2000 г.
    Поставлен 22 авг. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £136,890.00 and all other interest and charges due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    1 x stahl td 78 round continuous feeder serial no 700724,1 x blank sheet monitor for kd/td folders,2 x punch perforation after parallel fold and numerous other equipment items please refer to schedule to form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Udt Limited
    Транзакции
    • 22 авг. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 авг. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 29 окт. 1998 г.
    Поставлен 31 окт. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The principal sum of £400,500 together with all monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    1 x new muller martini star plus perfect binding line serial no: ka 94.02431. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 31 окт. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 15 апр. 1998 г.
    Поставлен 16 апр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The principal sum of £100,000 all monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    A fixed charge over the goods listed in the schedule attached to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 16 апр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 15 авг. 1997 г.
    Поставлен 16 авг. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £226,651.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the fixed charge
    Краткое описание
    1 x new heidelberg speedmaster 74 2 colour offset press with protector, serial number: 622245.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 16 авг. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattels mortgage
    Создан 13 дек. 1995 г.
    Поставлен 13 дек. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    One used miller tp 104 5 colour press. One used miller to 104 2 colour press. One used miller tp 29 2 colour press. One used heidelberg 102 vp speedmaster 4 colour press. One used wohlenberg golf 18 perfect binder. One used harris saddlebinder 562/642.. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Forward Trust Limited
    Транзакции
    • 13 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 июн. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Single debenture
    Создан 27 окт. 1995 г.
    Поставлен 01 нояб. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 01 нояб. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у THANET PRESS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    12 апр. 2011 г.Начало ликвидации
    23 сент. 2016 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Vincent John Green
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Практик
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Mark Newman
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Практик
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0